CLAVERHAM 98 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLAVERHAM 98 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03495314
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    • fabrication d'autres machines à usage spécial n.c.a. (28990) / Industries manufacturières

    Où se situe CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OVAL (1261) LIMITED20 janv. 199820 janv. 1998

    Quels sont les derniers comptes de CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:res re statement of account
    1 pagesLIQ MISC RES

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Claverham Bristol BS49 4NF à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 05 sept. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination de Mr Evan Francis Smith en tant qu'administrateur le 16 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christian Bruno Jean Idczak-Descat en tant qu'administrateur le 16 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Rajinder Singh Kullar en tant qu'administrateur le 16 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andreas Schell en tant que directeur le 16 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roger Robert Charles Buxton en tant que directeur le 06 avr. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Andrew Fowler en tant que directeur le 16 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2014

    État du capital au 24 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2012

    15 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 02 juil. 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH01

    État du capital au 09 juil. 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium acc of £39062000 cancelled 03/07/2013
    RES13

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 28 juin 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de CLAVERHAM 98 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementOC326366
    139113140001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrench129935690010
    KULLAR, Rajinder Singh
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Untied KingdomBritish74999290008
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,Irish73647690004
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Secrétaire
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Secrétaire
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    British77864400001
    MCCARTHY, Richard Thomas
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    Secrétaire
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    American128751220001
    PACKHAM, Robert William
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    Secrétaire
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    British137923770001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    BEAN, Alan David
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    Administrateur
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    British66656720002
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Administrateur
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BUXTON, Roger Robert Charles
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    Administrateur
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    United KingdomBritish78210300002
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Administrateur
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    EnglandBritish77864400001
    FOWLER, Peter Andrew
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    Administrateur
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    United KingdomBritish241110830001
    FROST, Simon Richard
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    British87291390001
    GARDINER, Michael Charles
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    Administrateur
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    United KingdomUk172073870001
    GINGRICH, James Lee
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Administrateur
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Us Citizen77865030001
    LEDUC, Robert Francis
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    Administrateur
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    UsaUs Citizen103629560001
    SAXE, Thomas William
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    Administrateur
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    UsaAmerican155680740001
    SCHELL, Andreas
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    UsaGerman176150890001
    WHYBROW, Ian Michael
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    British43349720001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    CLAVERHAM 98 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of life policies
    Créé le 04 mars 1998
    Livré le 11 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred to each beneficiary by the company or by any group company under or pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the policies re: simon frost £500,000 policy no: 3633347K. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the "principal debtors" (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and all other charges and expenses subject at all times to the provisions of the senior finance documents (as defined in the facilities agreement dated 23 january 1998 (as defined))
    Brèves mentions
    All moneys at the date of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CLAVERHAM 98 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 août 2014Commencement of winding up
    06 juin 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0