NETIQ LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNETIQ LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03498397
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NETIQ LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe NETIQ LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Lawn
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NETIQ LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour NETIQ LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13
    A9K2Y0FF

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01
    A98FP037

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600
    A98FP02Z

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 juil. 2020

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8Y26QXD

    legacy

    1 pagesSH20
    L8X9F4HD

    État du capital au 23 janv. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19
    L8X9F4HL

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    L8X9F4GX

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2019

    16 pagesAA
    A8K89CRF

    Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7XQ0G2P

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    16 pagesAA
    A7LBYVEJ

    Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6YAKN21

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Howard Norton le 08 déc. 2016

    2 pagesCH01
    X6IOAZ2Y

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD
    A6FIFMZV

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD
    A6FFT8HT

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    15 pagesAA
    A6FIF3BN

    Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5YW2GXT

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    16 pagesAA
    A5K284UY

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 16,200
    SH01
    X4ZI7WMP

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    12 pagesAA
    A4MVRY2J

    Cessation de la nomination de Dilip Kumar Upmanyu en tant que directeur le 31 juil. 2015

    1 pagesTM01
    X4F2Q9U0

    Nomination de Mr Darren Mark Curtis en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015

    2 pagesAP01
    X4F2Q9FM

    Changement d'adresse du siège social de 1 Arlington Square, Bracknell, Berkshire 1 Arlington Square Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1WA à The Lawn 22-30 Old Bath Road Newbury Berkshire RG14 1QN le 14 juil. 2015

    1 pagesAD01
    X4BJAB6Z

    Qui sont les dirigeants de NETIQ LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITHARD, Jane
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    197623040001
    CURTIS, Darren Mark
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    Administrateur
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    EnglandBritishCorporate Counsel200618370001
    NORTON, Graham Howard
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    Administrateur
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishAccountant149360780007
    BAYHA, Betsy Eileen
    1118 Pippin Creek Court
    FOREIGN San Jose
    California 95120
    Usa
    Secrétaire
    1118 Pippin Creek Court
    FOREIGN San Jose
    California 95120
    Usa
    United StatesAttorney88232310001
    GUILD, Jennifer
    South 25th Street
    98055 Renton
    750
    Wa
    Usa
    Secrétaire
    South 25th Street
    98055 Renton
    750
    Wa
    Usa
    AmericanDirector114660630002
    HWANG, Ching-Fa
    7667 Berland Court
    CA 95014 Cupertino
    California
    Usa
    Secrétaire
    7667 Berland Court
    CA 95014 Cupertino
    California
    Usa
    AmericanChief Executive Officer57034740001
    DE WARRENNE WALLER & CO LIMITED
    White Hart House
    High St Limpsfield
    RH8 0DT Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    White Hart House
    High St Limpsfield
    RH8 0DT Oxted
    Surrey
    46249770001
    ANDREWS, Marc Brian
    4 Woodleigh Mansions
    Larch Avenue
    SL5 0AW Sunninghill
    Administrateur
    4 Woodleigh Mansions
    Larch Avenue
    SL5 0AW Sunninghill
    BritishVice President Emea88865110002
    BARTH, James Arthur
    18237 Constitution Avenue
    Monte Sereno
    California 95030
    Usa
    Administrateur
    18237 Constitution Avenue
    Monte Sereno
    California 95030
    Usa
    AmericanAccountant87831710001
    BAYHA, Betsy Eileen
    1118 Pippin Creek Court
    FOREIGN San Jose
    California 95120
    Usa
    Administrateur
    1118 Pippin Creek Court
    FOREIGN San Jose
    California 95120
    Usa
    United StatesAttorney88232310001
    CHURCH, Simon Timothy
    37 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AR London
    Administrateur
    37 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AR London
    United KingdomBritishVp And General Manager107159780001
    DOCHERTY, James Thomas Robert
    35 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    35 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishSales Director141227850001
    DOCHERTY, James Thomas Robert
    4 Ancaster Drive
    SL5 8TR Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    4 Ancaster Drive
    SL5 8TR Ascot
    Berkshire
    BritishSales Director57511900001
    GUILD, Jennifer
    South 25th Street
    98055 Renton
    750
    Wa
    Usa
    Administrateur
    South 25th Street
    98055 Renton
    750
    Wa
    Usa
    United StatesAmericanDirector114660630007
    HAWN, Jeffrey Scott
    4004 Watersedge Drive
    Austin
    Texas 78731
    Usa
    Administrateur
    4004 Watersedge Drive
    Austin
    Texas 78731
    Usa
    UsaUnited StatesDirector115547960001
    HICKSON, James Louis
    4 Cui An Ath
    IRISH Barna
    Galway
    Ireland
    Administrateur
    4 Cui An Ath
    IRISH Barna
    Galway
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant123514920001
    HWANG, Ching-Fa
    7667 Berland Court
    CA 95014 Cupertino
    California
    Usa
    Administrateur
    7667 Berland Court
    CA 95014 Cupertino
    California
    Usa
    AmericanChief Executive Officer57034740001
    KILBANE, Seamus
    Ballad Bearna
    IRISH Calway
    Cluaniarn
    Co Galway
    Ireland
    Administrateur
    Ballad Bearna
    IRISH Calway
    Cluaniarn
    Co Galway
    Ireland
    IrishAccountant121121380002
    QUANTRELL, David George
    The Gables The Manor Paddock
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    The Gables The Manor Paddock
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishVice President And General Man94249360001
    UPMANYU, Dilip Kumar
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    Administrateur
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    UsaAmericanVp Finance192822860001
    VAN HOESEN, Richard
    19727 St Ann Court
    95070 Saratoga
    California
    Usa
    Administrateur
    19727 St Ann Court
    95070 Saratoga
    California
    Usa
    AmericanExecutive58344980001
    WINOKUR, Glenn
    213 Emerson Street
    CA 94301 Palo Alto
    California
    Usa
    Administrateur
    213 Emerson Street
    CA 94301 Palo Alto
    California
    Usa
    AmericanSales Vice President57034670001
    DW MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    White Hart House High Street
    Limpsfield
    RH8 0DT Oxted
    Surrey
    Administrateur
    White Hart House High Street
    Limpsfield
    RH8 0DT Oxted
    Surrey
    42617180006

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NETIQ LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Attachmate Sales Uk Limited
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn, 22-30
    England
    06 avr. 2016
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn, 22-30
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Company Registry
    Numéro d'enregistrement02338621
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NETIQ LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rental deposit deed
    Créé le 25 mars 2008
    Livré le 28 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rent deposit of £111,625 together with all accrued interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mckay Sercurities PLC
    Transactions
    • 28 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 04 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re: netiq limited barclays treasury deposit, deal no. 43844033. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 25 juil. 2000
    Livré le 28 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The rent deposit of £111,625 together with all accrued interest held in a deposit account with child & co of 1 fleet street,london EC4Y 1BD being the banker's of messrs.edwin coe,the solicitors specified in the rental deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Mckay Securities PLC
    Transactions
    • 28 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NETIQ LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 juil. 2020Commencement of winding up
    22 mars 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0