LINK MAILING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LINK MAILING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03498476 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LINK MAILING LIMITED ?
| Adresse du siège social | C12 Marquis Court Marquisway Team Valley NE11 0RU Gateshead |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LINK MAILING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour LINK MAILING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 20 pages | LIQ14 | ||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS à C12 Marquis Court Marquisway Team Valley Gateshead NE11 0RU le 30 mai 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 8 pages | LIQ02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2018 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge 034984760010, créée le 19 juil. 2017 | 15 pages | MR01 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 034984760008 | 1 pages | MR05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 034984760009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Kingsnorth House 1, Blenheim Way Kingstanding Birmingham B44 8LS England à Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS le 24 févr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Business Services Centre 446-450 Kingstanding Road Birmingham West Midlands B44 9SA à Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS le 24 févr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 034984760009 | 14 pages | MR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LINK MAILING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON, Deborah | Administrateur | 127 Princethorpe Way CV3 2FW Coventry West Midlands | England | British | 120825780001 | |||||
| JONES, Darren Raymond | Secrétaire | 16 Amersham Close CV5 9HH Coventry West Midlands | British | 94552640001 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| ACKLAND, Michael Edward | Administrateur | 10a Beaudesert Lane B95 5JY Henley In Arden West Midlands | England | British | 33087270002 | |||||
| ASKEY, Wayne | Administrateur | 37 Charlesworth Avenue Monks Path B90 4SE Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 31602690002 | |||||
| HOLMES, John Jeffrey | Administrateur | 8 Beeston Avenue Wakes Meadow NN3 9UG Northampton Northamptonshire | British | 56459630001 | ||||||
| JONES, Darren Raymond | Administrateur | Kingstanding Road B44 9SA Birmingham 446-450 West Midlands England | England | British | 94552640001 | |||||
| JONES, Darren Raymond | Administrateur | 16 Amersham Close CV5 9HH Coventry West Midlands | England | British | 94552640001 | |||||
| STRINGER, Gareth Peter | Administrateur | 35 Boiler House Electric Wharf CV1 4JU Coventry West Midlands | England | British | 120825740002 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LINK MAILING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mrs Deborah Donaldson | 31 juil. 2016 | Bodmin Road CV2 5DB Coventry Unit 1a Abbey Industrial Estate West Midlands England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
LINK MAILING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 19 juil. 2017 Livré le 20 juil. 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2013 Livré le 18 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. All monies, obligations and liabilities whatsoever (whether principal, interest or otherwise) which may now or at any time in the future be due owing or incurred by link mailing limited ("the company") to the lender, whether present or future, actual or contingent whether alone, severally or jointly as principal, guarantor surety or otherwise and in whatever name or style and whether on any current or other account, or in any other manner whatsoever together with interest and including (but without limitation) all expenses so that interest shall be calculated and compounded in accordance with the usual practise of the lender from time to time as well after as before judgment.. All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 27 sept. 2013 Livré le 01 oct. 2013 | En cours | ||
Brève description Unit 5 binns close tile hill coventry. Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 sept. 2003 Livré le 30 sept. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 19 déc. 2002 Livré le 02 janv. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The sum of £3,256. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 28 mars 2001 Livré le 10 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,407.50 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The rent deposit of £3,407.50. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 28 mars 2001 Livré le 06 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Brèves mentions £3,407.50. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| All assets debenture | Créé le 06 oct. 2000 Livré le 17 oct. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring or discounting arrangement | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge on all book debts | Créé le 01 juin 1998 Livré le 10 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under any factoring or discounting arrangement | |
Brèves mentions All book debts together with the benefit of all rights attached to such book debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 01 mai 1998 Livré le 06 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All liabilities of the company to the chargee under a lease dated 1 may 1998 | |
Brèves mentions The deposit being £3407.50. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
LINK MAILING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0