LINK MAILING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLINK MAILING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03498476
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LINK MAILING LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe LINK MAILING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C12 Marquis Court Marquisway
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LINK MAILING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour LINK MAILING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Changement d'adresse du siège social de Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS à C12 Marquis Court Marquisway Team Valley Gateshead NE11 0RU le 30 mai 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 09 mai 2019

    LRESEX

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Inscription de la charge 034984760010, créée le 19 juil. 2017

    15 pagesMR01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 034984760008

    1 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 034984760009 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2016

    8 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 janv. 2016

    État du capital au 20 janv. 2016

    • Capital: GBP 10,400
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Kingsnorth House 1, Blenheim Way Kingstanding Birmingham B44 8LS England à Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS le 24 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Business Services Centre 446-450 Kingstanding Road Birmingham West Midlands B44 9SA à Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS le 24 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2015

    État du capital au 10 févr. 2015

    • Capital: GBP 10,400
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital au 15 janv. 2014

    • Capital: GBP 10,400
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    8 pagesAA

    Inscription de la charge 034984760009

    14 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de LINK MAILING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DONALDSON, Deborah
    127 Princethorpe Way
    CV3 2FW Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    127 Princethorpe Way
    CV3 2FW Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish120825780001
    JONES, Darren Raymond
    16 Amersham Close
    CV5 9HH Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    16 Amersham Close
    CV5 9HH Coventry
    West Midlands
    British94552640001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secrétaire désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ACKLAND, Michael Edward
    10a Beaudesert Lane
    B95 5JY Henley In Arden
    West Midlands
    Administrateur
    10a Beaudesert Lane
    B95 5JY Henley In Arden
    West Midlands
    EnglandBritish33087270002
    ASKEY, Wayne
    37 Charlesworth Avenue
    Monks Path
    B90 4SE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    37 Charlesworth Avenue
    Monks Path
    B90 4SE Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish31602690002
    HOLMES, John Jeffrey
    8 Beeston Avenue
    Wakes Meadow
    NN3 9UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    8 Beeston Avenue
    Wakes Meadow
    NN3 9UG Northampton
    Northamptonshire
    British56459630001
    JONES, Darren Raymond
    Kingstanding Road
    B44 9SA Birmingham
    446-450
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Kingstanding Road
    B44 9SA Birmingham
    446-450
    West Midlands
    England
    EnglandBritish94552640001
    JONES, Darren Raymond
    16 Amersham Close
    CV5 9HH Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    16 Amersham Close
    CV5 9HH Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish94552640001
    STRINGER, Gareth Peter
    35 Boiler House
    Electric Wharf
    CV1 4JU Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    35 Boiler House
    Electric Wharf
    CV1 4JU Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish120825740002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Administrateur désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LINK MAILING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Deborah Donaldson
    Bodmin Road
    CV2 5DB Coventry
    Unit 1a Abbey Industrial Estate
    West Midlands
    England
    31 juil. 2016
    Bodmin Road
    CV2 5DB Coventry
    Unit 1a Abbey Industrial Estate
    West Midlands
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LINK MAILING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 19 juil. 2017
    Livré le 20 juil. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Art Share (Social Help Association for Reinvesting in Enterprise) Limited
    Transactions
    • 20 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2013
    Livré le 18 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. All monies, obligations and liabilities whatsoever (whether principal, interest or otherwise) which may now or at any time in the future be due owing or incurred by link mailing limited ("the company") to the lender, whether present or future, actual or contingent whether alone, severally or jointly as principal, guarantor surety or otherwise and in whatever name or style and whether on any current or other account, or in any other manner whatsoever together with interest and including (but without limitation) all expenses so that interest shall be calculated and compounded in accordance with the usual practise of the lender from time to time as well after as before judgment.. All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Black Country Reinvestment Society LTD
    Transactions
    • 18 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2013
    Livré le 01 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Unit 5 binns close tile hill coventry. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 juin 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 déc. 2002
    Livré le 02 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £3,256.
    Personnes ayant droit
    • Kindale Limited
    Transactions
    • 02 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 mars 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,407.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The rent deposit of £3,407.50.
    Personnes ayant droit
    • A.E.L. Clews (Investments) LTD
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 mars 2001
    Livré le 06 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    £3,407.50.
    Personnes ayant droit
    • A.E.L. Clews (Investments) Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 06 oct. 2000
    Livré le 17 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring or discounting arrangement
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rdm Factors Limited
    Transactions
    • 17 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge on all book debts
    Créé le 01 juin 1998
    Livré le 10 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any factoring or discounting arrangement
    Brèves mentions
    All book debts together with the benefit of all rights attached to such book debts.
    Personnes ayant droit
    • Sygnet Management Services Limited
    Transactions
    • 10 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 06 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of the company to the chargee under a lease dated 1 may 1998
    Brèves mentions
    The deposit being £3407.50.
    Personnes ayant droit
    • A.E.L.Clews (Investments) Limited
    Transactions
    • 06 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LINK MAILING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2019Commencement of winding up
    15 oct. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Wayne Harrison
    C12 Marquis Court Marquisway
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    practitioner
    C12 Marquis Court Marquisway
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    practitioner
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0