HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03499698 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Adresse du siège social | 23a Church Road BH14 8UF Poole England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Retrait de la demande de radiation de la société | 1 pages | DS02 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Nomination de Mr Nathaniel Jerome Meyohas en tant qu'administrateur le 01 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr David Danile Morris en tant qu'administrateur le 01 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Neville Barry Kahn en tant qu'administrateur le 02 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021 | 3 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Harris Pye House Harris Pye House Sutton Road Llandow Vale of Glamorgan CF71 7PA à 23a Church Road Poole BH14 8UF le 24 nov. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Dean Bell en tant que directeur le 25 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Deepak Munganahalli en tant qu'administrateur le 25 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Notification de Joulon Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 août 2022 | 2 pages | PSC02 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 15 sept. 2022 | 2 pages | PSC09 | ||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Cessation de Harris Pye Engineering Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 août 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 3 pages | AA | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Cessation de la nomination de Graham John Roach en tant que directeur le 31 août 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Dean Bell en tant qu'administrateur le 31 août 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHN, Neville Barry | Administrateur | Church Road BH14 8UF Poole 23a England | United Kingdom | British | 251066240001 | |||||
| MEYOHAS, Nathaniel Jerome | Administrateur | Church Road BH14 8UF Poole 23a England | United Kingdom | British | 200521410003 | |||||
| MORRIS, David Daniel | Administrateur | Church Road BH14 8UF Poole 23a England | United Kingdom | British | 253586270001 | |||||
| MUNGANAHALLI, Deepak | Administrateur | Church Road BH14 8UF Poole 23a England | United Arab Emirates | Indian | 300726080001 | |||||
| HUGHES, Joe Lewis | Secrétaire | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | 241158330001 | |||||||
| JAMES, Martin Norman | Secrétaire | 84 Heol Y Deri Rhiwbina CF4 6HJ Cardiff South Glamorgan | British | 61804900001 | ||||||
| TRIGG, Christopher Michael | Secrétaire | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan Wales | British | 58590840002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BELL, Dean | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | United Arab Emirates | Canadian | 286798170001 | |||||
| CARTER, David | Administrateur | 2 Sudan Cottage Sherfield English SO51 6FX Romsey Hampshire | British | 59958190001 | ||||||
| DAVID, Christopher | Administrateur | 23 Tyle House Close Llanmaes CF61 2XZ Llantwit Major Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | 120763520001 | |||||
| DAVID, Thomas | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | 249080880001 | |||||
| DAWSON, Michael Victor | Administrateur | 32 Westhouse Westgate CF71 7AR Cowbridge Vale Of Glamorgan | Wales | British | 27110540004 | |||||
| HAYDEN, David Anthony | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan Wales | Wales | Uk | 123653380001 | |||||
| HOPKINS, Nigel Allen | Administrateur | St. Andrews Road CF64 4HB Dinas Powys Wernlas United Kingdom | United Kingdom | British | 239567540001 | |||||
| JONES, Anthony Phillip | Administrateur | Lavernock House Fort Road Lavernock CF64 5UL Penarth South Glamorgan | United Kingdom | British | 2559220002 | |||||
| OSELAND, Alexander Duncan | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | 188842180001 | |||||
| PRENDERGAST, Mark Thomas | Administrateur | 35 Oakfield Road NP20 4LZ Newport | United Kingdom | British | 120818000001 | |||||
| RANJAN, Vishal | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | United Arab Emirates | Indian | 264644890001 | |||||
| ROACH, Graham John | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan | United Arab Emirates | Australian | 275774400001 | |||||
| TRIGG, Christopher Michael | Administrateur | Harris Pye House Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan Wales | United Kingdom | British | 58590840002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joulon Limited | 22 août 2022 | Grand Cayman KY1-1104 Grand Cayman Ugland House Cayman Islands | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Harris Pye Engineering Group Limited | 06 avr. 2016 | Sutton Road CF71 7PA Llandow Harris Pye House Vale Of Glamorgan Wales | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 27 janv. 2017 | 22 août 2022 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 31 mars 2007 Livré le 05 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 09 mai 2001 Livré le 09 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 17 août 2000 Livré le 24 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 11 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0