HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARRIS PYE BRIDGEND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03499698
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    • Réparation et entretien de navires et bateaux (33150) / Industries manufacturières

    Où se situe HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    23a Church Road
    BH14 8UF Poole
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARRIS PYE POWER SERVICES LIMITED04 déc. 201904 déc. 2019
    HARRIS PYE SOUTHAMPTON LIMITED11 janv. 201011 janv. 2010
    HARRIS PYE OUTFITTING LIMITED27 janv. 199827 janv. 1998

    Quels sont les derniers comptes de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Nomination de Mr Nathaniel Jerome Meyohas en tant qu'administrateur le 01 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Danile Morris en tant qu'administrateur le 01 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neville Barry Kahn en tant qu'administrateur le 02 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Harris Pye House Harris Pye House Sutton Road Llandow Vale of Glamorgan CF71 7PA à 23a Church Road Poole BH14 8UF le 24 nov. 2022

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Dean Bell en tant que directeur le 25 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Deepak Munganahalli en tant qu'administrateur le 25 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Joulon Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 août 2022

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 15 sept. 2022

    2 pagesPSC09

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de Harris Pye Engineering Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 août 2022

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Graham John Roach en tant que directeur le 31 août 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Dean Bell en tant qu'administrateur le 31 août 2021

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KAHN, Neville Barry
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    Administrateur
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    United KingdomBritish251066240001
    MEYOHAS, Nathaniel Jerome
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    Administrateur
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    United KingdomBritish200521410003
    MORRIS, David Daniel
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    Administrateur
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    United KingdomBritish253586270001
    MUNGANAHALLI, Deepak
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    Administrateur
    Church Road
    BH14 8UF Poole
    23a
    England
    United Arab EmiratesIndian300726080001
    HUGHES, Joe Lewis
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    241158330001
    JAMES, Martin Norman
    84 Heol Y Deri
    Rhiwbina
    CF4 6HJ Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    84 Heol Y Deri
    Rhiwbina
    CF4 6HJ Cardiff
    South Glamorgan
    British61804900001
    TRIGG, Christopher Michael
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Secrétaire
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    British58590840002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Dean
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    United Arab EmiratesCanadian286798170001
    CARTER, David
    2 Sudan Cottage
    Sherfield English
    SO51 6FX Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    2 Sudan Cottage
    Sherfield English
    SO51 6FX Romsey
    Hampshire
    British59958190001
    DAVID, Christopher
    23 Tyle House Close
    Llanmaes
    CF61 2XZ Llantwit Major
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    23 Tyle House Close
    Llanmaes
    CF61 2XZ Llantwit Major
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish120763520001
    DAVID, Thomas
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish249080880001
    DAWSON, Michael Victor
    32 Westhouse
    Westgate
    CF71 7AR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    32 Westhouse
    Westgate
    CF71 7AR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish27110540004
    HAYDEN, David Anthony
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    WalesUk123653380001
    HOPKINS, Nigel Allen
    St. Andrews Road
    CF64 4HB Dinas Powys
    Wernlas
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Andrews Road
    CF64 4HB Dinas Powys
    Wernlas
    United Kingdom
    United KingdomBritish239567540001
    JONES, Anthony Phillip
    Lavernock House
    Fort Road Lavernock
    CF64 5UL Penarth
    South Glamorgan
    Administrateur
    Lavernock House
    Fort Road Lavernock
    CF64 5UL Penarth
    South Glamorgan
    United KingdomBritish2559220002
    OSELAND, Alexander Duncan
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish188842180001
    PRENDERGAST, Mark Thomas
    35 Oakfield Road
    NP20 4LZ Newport
    Administrateur
    35 Oakfield Road
    NP20 4LZ Newport
    United KingdomBritish120818000001
    RANJAN, Vishal
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    United Arab EmiratesIndian264644890001
    ROACH, Graham John
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    United Arab EmiratesAustralian275774400001
    TRIGG, Christopher Michael
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Harris Pye House
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritish58590840002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Joulon Limited
    Grand Cayman
    KY1-1104
    Grand Cayman
    Ugland House
    Cayman Islands
    22 août 2022
    Grand Cayman
    KY1-1104
    Grand Cayman
    Ugland House
    Cayman Islands
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementCayman Islands
    Autorité légaleRegistrar Of Companies, Cayman Islands
    Lieu d'enregistrementCayman Islands
    Numéro d'enregistrement306868
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Harris Pye Engineering Group Limited
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    06 avr. 2016
    Sutton Road
    CF71 7PA Llandow
    Harris Pye House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Oui
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementWales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Cpm[Any Register
    Numéro d'enregistrement06178762
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    27 janv. 201722 août 2022La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    HARRIS PYE BRIDGEND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mars 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 mai 2001
    Livré le 09 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Michael Victor Dawson and Anthony Phillip Jones
    Transactions
    • 09 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0