CARDPOINT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARDPOINT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03516589
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED19 févr. 200919 févr. 2009
    CARDPOINT SERVICES LIMITED23 oct. 200823 oct. 2008
    MONEYBOX CORPORATION LIMITED17 janv. 200017 janv. 2000
    MONEY BOX CORPORATION LIMITED25 févr. 199825 févr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Michael Edward Keller en tant que directeur le 25 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Christopher Brewster en tant que directeur le 25 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Edward Keller en tant que secrétaire le 25 juin 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2015

    État du capital au 03 mars 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England à C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 pagesAD03

    Nomination de Jana Hile en tant qu'administrateur le 15 août 2014

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Jeremy David Kraft en tant que directeur le 30 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    19 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR le 16 juin 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2014

    État du capital au 25 févr. 2014

    • Capital: GBP 5,769,863.59
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Nomination de Mr Jeremy David Kraft en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Michael Keller en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de John Christopher Brewster en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CARDPOINT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HILE, Jana
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    EnglandAustralian192111080001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110396210002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Secrétaire
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Administrateur
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Administrateur
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    DINSMORE, Rikki Gavin
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    Administrateur
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    United KingdomBritish137100920001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HOLROYD, Richard Norton
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    Administrateur
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    British80220410001
    ISAACS, Vincent
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    Administrateur
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    British38705920001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORGAN, Colin John
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Administrateur
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Irish70867300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Administrateur
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Administrateur
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    United KingdomBritish116252510001
    ROBSON, Vincent Martin
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    Administrateur
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    British64602710001
    RYLAND, Stuart Antony
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish74367340001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Administrateur
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Administrateur
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Administrateur
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish99393670001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    CARDPOINT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A confirmatory security agreement
    Créé le 09 avr. 2010
    Livré le 13 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 05 févr. 2010
    Livré le 22 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 22 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 05 déc. 2007
    Livré le 15 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 15 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 02 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Agent or the Security Trustee). the Royalbank of Scotland the 'Original Pledgees'
    Transactions
    • 02 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Syndicated debenture
    Créé le 13 mars 2006
    Livré le 22 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustees for Thebeneficiaries
    Transactions
    • 22 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2005
    Livré le 15 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 15 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 09 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 03 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 03 juin 2003
    Livré le 21 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    52 authomated teller machines.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 21 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of chattels
    Créé le 03 juin 2003
    Livré le 19 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 19 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0