PROPERTIES PGPL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROPERTIES PGPL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03518609
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Capital Link
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Wales
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PEACOCK GROUP PROPERTIES LIMITED18 juin 199818 juin 1998
    ISSUENOTE LIMITED27 févr. 199827 févr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2012

    État du capital au 02 avr. 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed peacock group properties LIMITED\certificate issued on 29/02/12
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Mr Roy George Ellis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Killick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Killick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 avr. 2010

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS le 31 août 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 mars 2009

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 29 mars 2008

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2006

    9 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de PROPERTIES PGPL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Secrétaire
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Administrateur
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritishGroup Operations Director62596180004
    ELLIS, Roy George
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    Administrateur
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    WalesBritishDirector161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Administrateur
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector54276260003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Secrétaire
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Secrétaire
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British49912180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Administrateur
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritishDirector54831150003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Administrateur
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector75927820002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    PROPERTIES PGPL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2006
    Livré le 31 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transactions
    • 31 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Créé le 02 déc. 1999
    Livré le 17 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transactions
    • 17 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amendment variation guarantee and security deed
    Créé le 27 août 1998
    Livré le 11 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any of the financing documents and under the debenture
    Brèves mentions
    Property k/a 6-7 cibi walk abergavenny t/NOWA424980 41-44 church street abertillery t/no WA414286 59-61 market street ashby-de-la-zouche t/no LT183820 (and all the other properties listed) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0