PROPERTIES PGPL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROPERTIES PGPL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03518609 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROPERTIES PGPL LIMITED ?
Adresse du siège social | Capital Link Windsor Road CF24 5NG Cardiff Wales |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROPERTIES PGPL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 03 avr. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour PROPERTIES PGPL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed peacock group properties LIMITED\certificate issued on 29/02/12 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de Mr Roy George Ellis en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Killick en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Killick en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 03 avr. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS le 31 août 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 mars 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 29 mars 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2006 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b |
Qui sont les dirigeants de PROPERTIES PGPL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIS, Roy George | Secrétaire | 57 St Lawrence Park NP16 6DP Chepstow Gwent | British | 116788900001 | ||||||
BURNS, Neil Anthony | Administrateur | 8 Ffordd Gwern St. Fagans CF5 6PB Cardiff | Wales | British | Group Operations Director | 62596180004 | ||||
ELLIS, Roy George | Administrateur | Windsor Road CF24 5NG Cardiff Capital Link Wales | Wales | British | Director | 161784490001 | ||||
KIRK, Richard Stanley, Mr. | Administrateur | Palace Gardens Terrace W8 4RP London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 54276260003 | ||||
KILLICK, Michael David | Secrétaire | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Monmouthshire | British | 75927820002 | ||||||
WIGLEY, Islwyn Thomas | Secrétaire | 21 Windsor Road Radyr CF4 8BQ Cardiff | British | 49912180001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRYANT, Keith Ralph | Administrateur | Claremont Tidenham NP16 7JF Chepstow | United Kingdom | British | Director | 54831150003 | ||||
KILLICK, Michael David | Administrateur | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Monmouthshire | Wales | British | Director | 75927820002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
PROPERTIES PGPL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 23 janv. 2006 Livré le 31 janv. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) | Créé le 02 déc. 1999 Livré le 17 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Amendment variation guarantee and security deed | Créé le 27 août 1998 Livré le 11 sept. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any of the financing documents and under the debenture | |
Brèves mentions Property k/a 6-7 cibi walk abergavenny t/NOWA424980 41-44 church street abertillery t/no WA414286 59-61 market street ashby-de-la-zouche t/no LT183820 (and all the other properties listed) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0