WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED

WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03518803
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    • Extraction de pétrole brut (06100) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENDEAVOUR NORTH SEA LIMITED21 nov. 200621 nov. 2006
    TALISMAN EXPRO LIMITED19 déc. 200519 déc. 2005
    PALADIN EXPRO LIMITED13 janv. 200013 janv. 2000
    PALADIN RESOURCES (BITTERN) LIMITED02 sept. 199802 sept. 1998
    LUDGATE 162 LIMITED27 févr. 199827 févr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2020
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 févr. 2021
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation10 avr. 2021
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au27 févr. 2020
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Matthew Mulcahy en tant qu'administrateur le 15 mai 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati en tant que directeur le 15 mai 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Erik Brodahl en tant que directeur le 15 mai 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jon Bard Skabo en tant que directeur le 15 mai 2025

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jon Bard Skabo le 03 avr. 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Erik Brodahl le 03 avr. 2025

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Waldorf Production Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 avr. 2022

    2 pagesPSC05

    Nomination de Jon Bard Skabo en tant qu'administrateur le 24 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Paul Martyn Roger Tanner en tant qu'administrateur le 24 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Erik Brodahl en tant qu'administrateur le 24 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Erik Brodahl en tant que directeur le 29 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jon Bard Skabo en tant que directeur le 29 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 févr. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de Endeavour Energy Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    2 pagesPSC05

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name29 nov. 2019

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Mr Erik Brodahl en tant qu'administrateur le 22 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati en tant qu'administrateur le 22 oct. 2019

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    11 janv. 2021Second Filing A second filed AP01 was registered on 11.01.2021.

    Nomination de Mr Jon Bard Skabo en tant qu'administrateur le 22 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Catherine L. Stubbs en tant que directeur le 22 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Vinson & Elkins Rllp 24th Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY England à One St Peter's Square Manchester M2 3DE le 19 nov. 2019

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MULCAHY, Matthew
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    ScotlandEnglish206522020001
    TANNER, Paul Martyn Roger
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish287235120001
    CRAW, Jaquelynn Forsyth
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British109665360001
    ELLAM, Robert James
    Sycamore House Rectory Road
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    Secrétaire
    Sycamore House Rectory Road
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    British59115350001
    PAGANIS, Karen
    6426 Eaglewood Green Lane
    Spring
    Harris
    Tx 77379
    Usa
    Secrétaire
    6426 Eaglewood Green Lane
    Spring
    Harris
    Tx 77379
    Usa
    British126751310001
    POWELL, Sally Caroline
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    Secrétaire
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    British73499120003
    TEAGUE, Don
    2200 Willowick \ 16d
    Houston
    Texas
    77027
    Usa
    Secrétaire
    2200 Willowick \ 16d
    Houston
    Texas
    77027
    Usa
    American116981530001
    LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    Secrétaire désigné
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013900001
    BRODAHL, Erik
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian259915260001
    BRODAHL, Erik
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian289176780001
    BUCKEE, James William
    240/40th Avenue Sw
    Calgary
    Alberta
    T2s 0x3
    Canada
    Administrateur
    240/40th Avenue Sw
    Calgary
    Alberta
    T2s 0x3
    Canada
    British46195090001
    CHINTALAPATI, Venkata Vardhana Aaditya
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    EnglandBritish242565870001
    CRAW, Jaquelynn Forsyth
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British109665360001
    DAVISON, Paul
    Selwood Rickford
    Worplesdon
    GU3 3PJ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Selwood Rickford
    Worplesdon
    GU3 3PJ Guildford
    Surrey
    British59343700002
    FITZPATRICK, Robert Francis Trew
    Broad Hinton House
    Broad Hinton
    SN4 9PA Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Broad Hinton House
    Broad Hinton
    SN4 9PA Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish95621990001
    FRANKLIN, Roy Alexander
    Culmer Farm House
    Petworth Road,Wormley
    GU8 5SW Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Culmer Farm House
    Petworth Road,Wormley
    GU8 5SW Godalming
    Surrey
    British5667230002
    GRENZ, Carl
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9UE London
    Citypoint 33rd Floor
    Administrateur
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9UE London
    Citypoint 33rd Floor
    UkBritish146425220001
    GRIFFITHS, David
    Merrydawns
    Meadowside
    KT23 3LG Great Bookham
    Surrey
    Administrateur
    Merrydawns
    Meadowside
    KT23 3LG Great Bookham
    Surrey
    British115393840001
    MCDOWELL, Cuthbert John
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    Administrateur
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish54783520001
    MITHEN, David Patrick
    Carpe Diem House Daviot
    AB51 0HZ Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Carpe Diem House Daviot
    AB51 0HZ Inverurie
    Aberdeenshire
    British60585460001
    MUNNS, James William
    31 Chantry Hurst
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    31 Chantry Hurst
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish96456540001
    POWELL, Sally Caroline
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    Administrateur
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    UkBritish73499120003
    REID, Colin John Watson
    6 Moray Place
    AB15 4AF Aberdeen
    Administrateur
    6 Moray Place
    AB15 4AF Aberdeen
    ScotlandBritish87210540002
    SHEPPARD, Mary Jacqueline
    1316 Prospect Avenue Sw
    Calgary
    T2T OX5 Alberta
    Canada
    Administrateur
    1316 Prospect Avenue Sw
    Calgary
    T2T OX5 Alberta
    Canada
    Canadian47103050001
    SKABO, Jon Bard
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian304275580001
    SKABO, Jon Bard
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian289179680001
    STUBBS, Catherine L.
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    United StatesAmerican167197320001
    WALKER, Nicholas John Robert
    3 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Administrateur
    3 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    British109709500001
    LUDGATE NOMINEES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    Administrateur désigné
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013890001
    LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    Administrateur désigné
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013900001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Waldorf Production Uk Plc
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    30 juin 2016
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies Of England And Wales
    Numéro d'enregistrement05030838
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 oct. 2019
    Livré le 24 oct. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 24 oct. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    Security agreement
    Créé le 08 févr. 2010
    Livré le 16 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other grantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares of stock, all indebtedness the securites accounts, the account collateral, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    Transactions
    • 16 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2010
    Livré le 15 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including the relevant project accounts, any present or future insurances together with all related property rights, the hedging agreements, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    Transactions
    • 15 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2006
    Livré le 10 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the all property and assets present and future including the relevant project accounts, insurances, and the hedging agreements,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    Transactions
    • 10 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental security agreement
    Créé le 01 nov. 2006
    Livré le 13 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in all equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares, all indebtedness, all contracts, the account collateral, intellectual property collateral,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    Transactions
    • 13 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An omnibus letter of set-off
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 31 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 10 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge all of its rights to and title and interest from time to time in the whole of its property (including, for the avoidance of doubt, any insurance proceeds), assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever, present and future, including its uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Trustee for the Secured Creditors(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 25 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor or any obligor to the agent and the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 21 août 2002
    Livré le 27 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the chargee as agent and trustee for itself, the other finance parties and the overdraft bank (the "agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of its property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transactions
    • 27 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 18 déc. 2000
    Livré le 04 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) or to the overdraft bank under or pursuant to the finance documents (or any of them) or the overdraft (all as defined therein)
    Brèves mentions
    All of its right title and interest in the whole of its property, assets, rights and revenues including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited(As Agent and Trustee for Itself and for the Other Finance Parties and the Overdraft Bank ("Theagent") )
    Transactions
    • 04 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0