HELTER SKELTER AGENCY LIMITED

HELTER SKELTER AGENCY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHELTER SKELTER AGENCY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03522889
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    • Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. (93290) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Pancras Square
    N1C 4AG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WORLD AGENCY LIMITED06 mars 199806 mars 1998

    Quels sont les derniers comptes de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 20 sept. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Boyd Johnston Muir en tant que directeur le 02 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 4 Pancras Square London N1C 4AG

    1 pagesAD04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Boyd Johnston Muir le 23 juil. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Abolanle Abioye le 23 juil. 2018

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS à 4 Pancras Square London N1C 4AG le 23 juil. 2018

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Universal Srg Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juil. 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Michael Constant en tant que directeur le 28 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Paramjit Jassal en tant qu'administrateur le 18 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Brown en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Lloyd Carmel en tant qu'administrateur le 31 mars 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2017 avec mises à jour

    8 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABIOYE, Abolanle
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Secrétaire
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    British88802330001
    CARMEL, Simon Lloyd
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish172950720001
    JASSAL, Paramjit
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish16770570003
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    METCALFE, Philip John
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    Secrétaire
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    British59138870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Secrétaire
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ASHURST, William Anthony
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    Administrateur
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    United KingdomBritish123516100001
    BANKS, Emma Louise
    20 Rozel Road
    Clapham
    SW4 0EZ London
    Administrateur
    20 Rozel Road
    Clapham
    SW4 0EZ London
    British40070490001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Administrateur
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritish163199590001
    CASS, Michael Trevor
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    British2320620002
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Administrateur
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritish43836310003
    DAVIES, Hywel Hadley
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    Administrateur
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    British13515170001
    FRANKLIN, Paul Robert
    Spurstow House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TF Spurstow
    Cheshire
    Administrateur
    Spurstow House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TF Spurstow
    Cheshire
    British110798290001
    GREEK, Michael Daniel
    122 Glengall Road
    NW6 7HH London
    Administrateur
    122 Glengall Road
    NW6 7HH London
    British94819480001
    HUFFAM, Ian Michael
    28 Great Jubilee Wharf
    78-80 Wapping Wall
    E1W 3TH London
    Administrateur
    28 Great Jubilee Wharf
    78-80 Wapping Wall
    E1W 3TH London
    United KingdomBritish75681420002
    JACKSON, John William
    Sedgewick Park
    RH13 6QQ Nuthurst
    West Sussex
    Administrateur
    Sedgewick Park
    RH13 6QQ Nuthurst
    West Sussex
    British13435320001
    METCALFE, Philip John
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    Administrateur
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    British59138870001
    MILLER, Michael David
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish44250870002
    MUIR, Boyd Johnston
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United StatesBritish172824510001
    NASH, Peter
    Flat F 9 Warwick Square
    SW1V 2AA London
    Administrateur
    Flat F 9 Warwick Square
    SW1V 2AA London
    British75681480003
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Administrateur
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritish76655520001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    15 nov. 2016
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00284340
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01890289
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HELTER SKELTER AGENCY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juin 2002
    Livré le 27 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Créé le 11 août 2000
    Livré le 30 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Brèves mentions
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 30 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Créé le 01 juil. 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Brèves mentions
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 oct. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 sept. 1998
    Livré le 16 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0