HELTER SKELTER AGENCY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HELTER SKELTER AGENCY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03522889 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4 Pancras Square N1C 4AG London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 20 sept. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Boyd Johnston Muir en tant que directeur le 02 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 4 Pancras Square London N1C 4AG | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Boyd Johnston Muir le 23 juil. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Abolanle Abioye le 23 juil. 2018 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS à 4 Pancras Square London N1C 4AG le 23 juil. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Universal Srg Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juil. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Michael Constant en tant que directeur le 28 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Paramjit Jassal en tant qu'administrateur le 18 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Brown en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Lloyd Carmel en tant qu'administrateur le 31 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2017 avec mises à jour | 8 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOYE, Abolanle | Secrétaire | Pancras Square N1C 4AG London 4 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| CARMEL, Simon Lloyd | Administrateur | Pancras Square N1C 4AG London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 172950720001 | |||||
| JASSAL, Paramjit | Administrateur | Pancras Square N1C 4AG London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 16770570003 | |||||
| JOY, Matthew Robert | Secrétaire | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
| METCALFE, Philip John | Secrétaire | 5 Alba Court Alba Gardens NW11 6NP London | British | 59138870001 | ||||||
| STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Secrétaire | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| ASHURST, William Anthony | Administrateur | Flat 6 Richardsons Mews W1T 6BS London Middlesex | United Kingdom | British | 123516100001 | |||||
| BANKS, Emma Louise | Administrateur | 20 Rozel Road Clapham SW4 0EZ London | British | 40070490001 | ||||||
| BROWN, Andrew | Administrateur | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 163199590001 | |||||
| CASS, Michael Trevor | Administrateur | 63 Evelyn Drive HA5 4RL Pinner Middlesex | British | 2320620002 | ||||||
| CONSTANT, Richard Michael | Administrateur | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| DAVIES, Hywel Hadley | Administrateur | 2b Florence Road W5 3TX London | British | 13515170001 | ||||||
| FRANKLIN, Paul Robert | Administrateur | Spurstow House Peckforton Hall Lane CW6 9TF Spurstow Cheshire | British | 110798290001 | ||||||
| GREEK, Michael Daniel | Administrateur | 122 Glengall Road NW6 7HH London | British | 94819480001 | ||||||
| HUFFAM, Ian Michael | Administrateur | 28 Great Jubilee Wharf 78-80 Wapping Wall E1W 3TH London | United Kingdom | British | 75681420002 | |||||
| JACKSON, John William | Administrateur | Sedgewick Park RH13 6QQ Nuthurst West Sussex | British | 13435320001 | ||||||
| METCALFE, Philip John | Administrateur | 5 Alba Court Alba Gardens NW11 6NP London | British | 59138870001 | ||||||
| MILLER, Michael David | Administrateur | High Trees 15a Linksway HA6 2XA Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 44250870002 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Administrateur | Pancras Square N1C 4AG London 4 United Kingdom | United States | British | 172824510001 | |||||
| NASH, Peter | Administrateur | Flat F 9 Warwick Square SW1V 2AA London | British | 75681480003 | ||||||
| TAYLOR, Andrew John | Administrateur | The Bridge House Bisham Road SL7 1RP Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 54448520001 | |||||
| WALLACE, Paul Frederick | Administrateur | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | 76655520001 | |||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HELTER SKELTER AGENCY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Srg Group Limited | 15 nov. 2016 | Pancras Square N1C 4AG London 4 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Universal Srg Artist Services Limited | 06 avr. 2016 | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HELTER SKELTER AGENCY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 14 juin 2002 Livré le 27 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed") | Créé le 11 août 2000 Livré le 30 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined) | |
Brèves mentions L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 | Créé le 01 juil. 1999 Livré le 09 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined) | |
Brèves mentions All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 29 oct. 1998 Livré le 17 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 oct. 1998 Livré le 06 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 sept. 1998 Livré le 16 sept. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0