VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03526757 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Jessop House Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Glos United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jeffrey P. Pritchett le 25 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Neptune Directors Limited le 27 juin 2012 | 2 pages | CH02 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Neptune Secretaries Limited le 27 juin 2012 | 2 pages | CH04 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 95 the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1WG le 26 juin 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Subdivision des actions au 07 févr. 2011 | 5 pages | SH02 | ||||||||||||||
Statuts | 29 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Nomination de Jeffrey P. Pritchett en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Barry Kohn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2006 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2005 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a |
Qui sont les dirigeants de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPTUNE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos | 84239630002 | |||||||
PRITCHETT, Jeffrey P. | Administrateur | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | Usa | American | Director | 154802530002 | ||||
NEPTUNE DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos | 79579520002 | |||||||
BRUCE-MORGAN, Llewellyn | Secrétaire | 15 Lady Margaret Road Kentish Town NW5 2NG London | British | 8164040002 | ||||||
FISHER, Angus William Murray | Secrétaire | Coledown House Vicarage Lane, Curdridge S032 2DP Southampton Hants | British | 122903010001 | ||||||
HOWARD, John | Secrétaire | 714 Avila Drive Davidsonville Maryland 21035 America | American | Clo And Secretary | 107278560001 | |||||
MILLER, Moira Josephine | Secrétaire | 4 Nye Way Bovingdon HP3 0HX Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 14691880002 | ||||||
SULTOON, Jeffrey Alan | Secrétaire | 9 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | British | 19011680001 | ||||||
WILSHER, Bryan Guy | Secrétaire | 21 Stamford Road N1 4JP London | British | 3588500007 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ANGELSON, Mark Alan | Administrateur | 876 Park Avenue Penthouse North 10021 New York Usa | Usa | Solicitor/Company Director | 54679960003 | |||||
DURBIN, Dean | Administrateur | 19001 Windsor Forest Road Mt Airy 21771 Maryland U S A | American | President C F O | 81493710001 | |||||
KOHN, Barry C | Administrateur | 10935 Hastings Ln 43065 Powell Oh Usa | American | Director | 121760800001 | |||||
MOORE, George Herbert | Administrateur | 4 Warwick Road W5 3XJ London | British | Accountant | 107278690001 | |||||
ROLAND, Donald Edward | Administrateur | 4 Norwood Road Annapolis Maryland 21401 Usa | American | Non Exec Chairman | 71621920001 | |||||
ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie | Administrateur | Stationsweg 26 Oosterbeek 6861 Eh Netherlands | Dutch | Company Director | 74228750001 | |||||
TREMBLAY, Stephen E. | Administrateur | 341 Streett Circle MD 2105 Forest Hill Usa | American | Cfo And Treasurer | 111252480001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 22 déc. 2004 Livré le 11 janv. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge over shares | Créé le 22 déc. 2004 Livré le 11 janv. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its right, title and interest from time to time in and to; the original shares; all dividends; all further shares; and all derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 janv. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over shares and inter company promissory notes | Créé le 22 juin 1998 Livré le 09 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from company to the bank creditors (as defined) arising out of or in connection with any credit document (as defined); all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and the other creditors (as defined) under or arising out of or in connection with any interest rate protection (as defined) or other hedging agreement (as defined) or under the guarantee and any and all sums advanced by the collateral agent in order to preserve the secured property and/or its security interest herein and all amounts paid by any indemnitee to which such indemnitee has the right to reimbursement under clause 5.3 of the deed | |
Brèves mentions All the shares and all the notes and any proceeds of any or all of the foregoing. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over shares | Créé le 13 mars 1998 Livré le 20 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All those shares representing the whole of the issued shares in pismo limited and the whole of the issued shares in troypeak limited and any proceeds of sale or other realisation of such shares. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0