VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED

VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03526757
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jessop House
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Glos
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BIG FLOWER DIGITAL SERVICES LIMITED09 mars 199809 mars 1998

    Quels sont les derniers comptes de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeffrey P. Pritchett le 25 juin 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Neptune Directors Limited le 27 juin 2012

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Neptune Secretaries Limited le 27 juin 2012

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de 95 the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1WG le 26 juin 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2012

    État du capital au 09 mars 2012

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Subdivision des actions au 07 févr. 2011

    5 pagesSH02

    Statuts

    29 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sub-division of shares 07/02/2011
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Nomination de Jeffrey P. Pritchett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Barry Kohn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    15 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEPTUNE SECRETARIES LIMITED
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    Secrétaire
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    84239630002
    PRITCHETT, Jeffrey P.
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Administrateur
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    UsaAmericanDirector154802530002
    NEPTUNE DIRECTORS LIMITED
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    Administrateur
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    79579520002
    BRUCE-MORGAN, Llewellyn
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    Secrétaire
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    British8164040002
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Secrétaire
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    British122903010001
    HOWARD, John
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    Secrétaire
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    AmericanClo And Secretary107278560001
    MILLER, Moira Josephine
    4 Nye Way
    Bovingdon
    HP3 0HX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    4 Nye Way
    Bovingdon
    HP3 0HX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British14691880002
    SULTOON, Jeffrey Alan
    9 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    9 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    British19011680001
    WILSHER, Bryan Guy
    21 Stamford Road
    N1 4JP London
    Secrétaire
    21 Stamford Road
    N1 4JP London
    British3588500007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Administrateur
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    UsaSolicitor/Company Director54679960003
    DURBIN, Dean
    19001 Windsor Forest Road
    Mt Airy
    21771 Maryland
    U S A
    Administrateur
    19001 Windsor Forest Road
    Mt Airy
    21771 Maryland
    U S A
    AmericanPresident C F O81493710001
    KOHN, Barry C
    10935 Hastings Ln
    43065 Powell
    Oh
    Usa
    Administrateur
    10935 Hastings Ln
    43065 Powell
    Oh
    Usa
    AmericanDirector121760800001
    MOORE, George Herbert
    4 Warwick Road
    W5 3XJ London
    Administrateur
    4 Warwick Road
    W5 3XJ London
    BritishAccountant107278690001
    ROLAND, Donald Edward
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    Administrateur
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    AmericanNon Exec Chairman71621920001
    ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Administrateur
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    DutchCompany Director74228750001
    TREMBLAY, Stephen E.
    341 Streett Circle
    MD 2105 Forest Hill
    Usa
    Administrateur
    341 Streett Circle
    MD 2105 Forest Hill
    Usa
    AmericanCfo And Treasurer111252480001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    VERTIS DIGITAL SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 11 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over shares
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 11 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right, title and interest from time to time in and to; the original shares; all dividends; all further shares; and all derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank (The "Collateral Agent")
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares and inter company promissory notes
    Créé le 22 juin 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from company to the bank creditors (as defined) arising out of or in connection with any credit document (as defined); all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and the other creditors (as defined) under or arising out of or in connection with any interest rate protection (as defined) or other hedging agreement (as defined) or under the guarantee and any and all sums advanced by the collateral agent in order to preserve the secured property and/or its security interest herein and all amounts paid by any indemnitee to which such indemnitee has the right to reimbursement under clause 5.3 of the deed
    Brèves mentions
    All the shares and all the notes and any proceeds of any or all of the foregoing.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company (The "Collateral Agent") for the Benefit of the Secured Creditors
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 13 mars 1998
    Livré le 20 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those shares representing the whole of the issued shares in pismo limited and the whole of the issued shares in troypeak limited and any proceeds of sale or other realisation of such shares.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company
    Transactions
    • 20 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0