D & G COACH & BUS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéD & G COACH & BUS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03528882
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de D & G COACH & BUS LIMITED ?

    • Autre transport terrestre de voyageurs (49390) / Transports et stockage

    Où se situe D & G COACH & BUS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ground Floor Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de D & G COACH & BUS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour D & G COACH & BUS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de The Wellington 78 High Street Uttoxeter Staffordshire ST14 7JD à Ground Floor Seneca House Links Point Amy Johnson Way Blackpool Lancashire FY4 2FF le 23 juin 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juin 2015

    LRESSP

    Période comptable précédente prolongée du 31 août 2014 au 28 févr. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 avr. 2015

    État du capital au 30 avr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Backhouse Reeves le 24 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Heidi Holland le 24 oct. 2014

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de * 26 the Meadows Kingstone Uttoxeter Staffordshire ST14 8QE* le 15 mai 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2014

    État du capital au 14 mars 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013

    9 pagesAA

    Comptes modifiés jusqu'au 31 août 2012

    8 pagesAAMD

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Backhouse Reeves le 28 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2011

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Heidi Pugh le 13 août 2011

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de * D & G Coach and Bus Ltd Mossfield Road Adderley Green Longton Stoke on Trent Staffordshire ST3 5BW* le 09 juin 2011

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de D & G COACH & BUS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLLAND, Heidi
    Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Ground Floor Seneca House
    Lancashire
    Secrétaire
    Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Ground Floor Seneca House
    Lancashire
    BritishPersonal Assistant124792130002
    PEDDLE, Julian Henry
    Dovecliff
    Barrow Hill Rocester
    ST14 5BX Uttoxeter
    Administrateur
    Dovecliff
    Barrow Hill Rocester
    ST14 5BX Uttoxeter
    EnglandBritishDirector6284620002
    REEVES, David Backhouse
    Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Ground Floor Seneca House
    Lancashire
    Administrateur
    Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Ground Floor Seneca House
    Lancashire
    EnglandBritishDirector57785670005
    BAILEY, Robert Anthony
    Beech Tree Cottage 51 Longton Road
    Barlaston
    ST12 9AR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Beech Tree Cottage 51 Longton Road
    Barlaston
    ST12 9AR Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishSolicitor50916840002
    LOUGHHEAD, Paul Johnathan
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglishCommercial Manager73020030001
    REEVES, David Backhouse
    26 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    26 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector57785670004
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secrétaire désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    HENDERSON, Gerald
    10 Parklands Drive
    Wychwood Village
    CW2 5FH Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    10 Parklands Drive
    Wychwood Village
    CW2 5FH Crewe
    Cheshire
    BritishDirector57785710009
    LOUGHEAD, Paul Jonathan
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCommericial Manager119218480001
    LOUGHHEAD, Paul Johnathan
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    48 Meadow Road
    Barlaston
    ST12 9EJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandEnglishCommercial Manager73020030001
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Administrateur désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    D & G COACH & BUS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 sept. 2010
    Livré le 11 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 2B/c mossfield road adderley green stoke on trent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2007
    Livré le 29 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 26 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or liyell limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 30 juin 2005
    Livré le 07 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold being plot 2B and plot 2C mossfield rd,stoke on trent; SF499009. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 juin 2005
    Livré le 23 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,875.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Plot 2B and 2C mossfields road moddfields industrial estate longton stoke on trent t/n SF499009.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2004
    Livré le 01 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,875.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property known as plot 2C mossfields road mossfields industrial estate longton stoke on trent.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2004
    Livré le 01 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,875.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The freehold property known as plot 2B mossfields industrial estate longton stoke on trent.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy,intimation dated 18 february 2004 and
    Créé le 18 févr. 2004
    Livré le 28 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Halifax life LTD policy number ASSH007449 dated 22/08/03 sum £150000 life assured gerald henderson together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy, intimation dated 18 february 2004 and
    Créé le 18 févr. 2004
    Livré le 28 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Halifax financial services policy number ASSH007160 dated 22/08/2003 and sum £150000 life assured david backhouse together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 2003
    Livré le 04 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 2001
    Livré le 06 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    D & G COACH & BUS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juin 2015Commencement of winding up
    01 nov. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Ian Williamson
    Ground Floor Seneca House Links Point Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    practitioner
    Ground Floor Seneca House Links Point Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0