A D AVIATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéA D AVIATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03531987
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de A D AVIATION LIMITED ?

    • Transport aérien de passagers non régulier (51102) / Transports et stockage

    Où se situe A D AVIATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    Cheshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de A D AVIATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEONOPAL LIMITED20 mars 199820 mars 1998

    Quels sont les derniers comptes de A D AVIATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 avr. 2016

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour A D AVIATION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour A D AVIATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 15 avr. 2016

    2 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2016 au 15 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Michael James Newton en tant qu'administrateur le 31 mai 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pauline Anne Norstrom en tant que directeur le 18 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael James Newton en tant que directeur le 19 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Pamela Doroszkiewicz en tant que secrétaire le 17 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie en tant que directeur le 17 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 avr. 2016

    État du capital au 13 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,265,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England à No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB le 12 mars 2016

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1200 Daresbury Park, Daresbury, Warrington Cheshire WA4 4HS à No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB le 12 mars 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Ms Pauline Anne Norstrom en tant qu'administrateur le 01 mars 2016

    2 pagesAP01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mars 2015

    État du capital au 23 mars 2015

    • Capital: GBP 1,265,000
    SH01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mars 2014

    État du capital au 28 mars 2014

    • Capital: GBP 1,265,000
    SH01

    Comptes établis au 30 juin 2013

    17 pagesAA

    Comptes établis au 30 juin 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de A D AVIATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    BritishAccounts Manager82853440002
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    British24712770003
    SPROTT, David
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    Secrétaire
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    BritishDirector106628420001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector169499300001
    HORNE, Michael Andrew
    2 Handforth Close
    Thelwall
    WA4 2JR Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    2 Handforth Close
    Thelwall
    WA4 2JR Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector32751960002
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishCompany Director148506110001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector51578980003
    WISEBERG, Adam Harris
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector141666340001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    A D AVIATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 oct. 2011
    Livré le 22 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 oct. 2011
    Livré le 21 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Michael James Newton
    Transactions
    • 21 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 31 juil. 2009
    Livré le 18 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re a d aviation limited business base rate tracker a/n 33669610.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Aircraft mortgage
    Créé le 28 oct. 2008
    Livré le 08 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cessna 550 citation ii registration mark g-vuez serial no 550-0008 together with all equipment and the proceeds of all policies of insurance now or in the future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Capital (UK) PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 24 mars 2006
    Livré le 24 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest present and future in and to one cessna citation isp aircraft, registration mark g-vuez, airframe msm 550-0008, two pratt & whitney JT15D-4 engines bearing msm pc-E70125 and pc-E70126 and interest in and to the warranty proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Equipment Finance LTD
    Transactions
    • 24 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 03 oct. 2001
    Livré le 05 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any of the facility agreement dated 21 september 2001 and the mortgage dated 3 october 2001 between the parties (each as amended from time to time) and any other document or instrument now or hereafter entered into between any of the parties
    Brèves mentions
    By way of first priority legal mortgage cessna citation aircraft UK reg mark g-flvu (as defined) by way of assignment any and all contracts or policies or insurance any monies or other compensation receivable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge European Equipment Finance Limited
    Transactions
    • 05 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0