MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03537076 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Adresse du siège social | 17 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 janv. 2026 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 oct. 2026 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 sept. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 sept. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 sept. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2025 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Charlotte Wallwork en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 août 2024 | 2 pages | PSC01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 19 Weatherall Close Dunkirk Faversham Kent ME13 9UL England à 17 Weatherall Close Dunkirk Faversham ME13 9UL le 27 août 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mrs Charlotte Wallwork en tant qu'administrateur le 15 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ann Toni Young en tant que directeur le 31 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2024 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2023 | 5 pages | AA | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de David Rose en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Robert James Field en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Ann Toni Young en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 2 pages | PSC01 | ||
Notification de Nigel Compton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 2 pages | PSC01 | ||
Notification de Diane Compton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 2 pages | PSC01 | ||
Notification de Gary Weatherall en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 2 pages | PSC01 | ||
Notification de Linda Weaver en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de la nomination de Robert James Field en tant que directeur le 30 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de David Rose en tant que directeur le 31 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2021 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2021 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Terrence John Young en tant que directeur le 01 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de Terrence John Young en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Qui sont les dirigeants de MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTON, Diane | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | England | British | Company Director | 126560620002 | ||||
COMPTON, Nigel | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | England | British | Manager | 126560630002 | ||||
WALLWORK, Charlotte | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 22 Kent England | England | British | Finance Officer | 326523200001 | ||||
WEATHERALL, Gary | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | England | British | Company Director | 281922320001 | ||||
WEAVER, Linda | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | England | British | Company Director | 281922160001 | ||||
GRAY, Lisa Anne Mercedes | Secrétaire | 12 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Training Consultant | 64625930001 | |||||
GRAY, Stephen James | Secrétaire | 12 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Secretary | 64625840001 | |||||
HARVEY, Peter | Secrétaire | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 18 Kent United Kingdom | 151303100001 | |||||||
SMITH, Paula Bridget | Secrétaire | 11 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Accountant | 81876470001 | |||||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 22 Melton Street NW1 2BW London | 38636470004 | |||||||
CRIPPS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Seymour House 11-13 Mount Ephraim Road TN1 1EN Tunbridge Wells Kent | 72315050005 | |||||||
PEVEREL OM LIMITED | Secrétaire | Marlborough House Wigmore Place Wigmore Lane LU2 9EX Luton Bedfordshire | 51204430002 | |||||||
ALLUM, Christopher George | Administrateur | 19 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Retired | 81876090001 | |||||
BLUNDELL, Lisa | Administrateur | 13 Weatherall Close ME13 9UL Faversham Kent | British | Sales | 81876660001 | |||||
CADDY, Mark Anthony Graham | Administrateur | 27 Horselees Road ME13 9TG Boughton Kent | England | British | It Consultant | 169382220001 | ||||
CLARKE, Ian Richard | Administrateur | 1 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Director | 81876000001 | |||||
CLARKE, Odette | Administrateur | 1 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Admin Manager | 87680440001 | |||||
ELLIS, Michael Francis | Administrateur | Wallside House 12 Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells Kent | England | British | Solicitor | 52497080002 | ||||
EMPTAGE, Amanda Karen | Administrateur | 10 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Housewife | 81876750001 | |||||
FERMOR, Andrew Patrick Lionel | Administrateur | Wallside House 12 Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells Kent | England | British | Director | 14929660001 | ||||
FIELD, Robert James | Administrateur | 27 New Dover Road CT1 3DN Canterbury Camburgh House Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 174357800003 | ||||
GRAY, Lisa Anne Mercedes | Administrateur | 12 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | United Kingdom | British | Training Consultant | 64625930001 | ||||
GRAY, Stephen James | Administrateur | 12 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Secretary | 64625840001 | |||||
HARVEY, Peter | Administrateur | 18 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | England | British | Retired | 103422560001 | ||||
KITCHEN, Anthony Paul | Administrateur | Acer Lodge 14 Weatherall Close ME13 9UL Faversham Kent | British | Sales Executive | 112217800001 | |||||
KNIGHT, Gillian Veronica | Administrateur | 17 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Civil Servant | 54015650002 | |||||
LING, Darril | Administrateur | 15 Weatherall Close ME13 9UL Dunkirk Faversham | British | Sales | 81876220001 | |||||
LOCKYER, John Ben | Administrateur | Wallside House 12 Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells Kent | British | Legal Executive | 72362790002 | |||||
MITCHELL, Ian Samuel James | Administrateur | 5 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | England | British | Director | 66901350002 | ||||
NITHSDALE, John Ronald | Administrateur | 18 Weatherall Close ME13 9UL Dunkirk Kent | British | Garage Owner | 81875860001 | |||||
ROSE, David | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 8 Kent England | England | British | Office Manager | 195032140001 | ||||
SMITH, Paula Bridget | Administrateur | 11 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Accountant | 81876470001 | |||||
WINDRIDGE, Gillian Elizabeth | Administrateur | 6 Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham Kent | British | Housewife | 95578030001 | |||||
YOUNG, Ann Toni | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | England | British | Company Director | 281924690001 | ||||
YOUNG, Ronald Alan | Administrateur | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 18 Kent England | United Kingdom | British | Management Consultant | 151306650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MALLABY RISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mrs Charlotte Wallwork | 15 août 2024 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 22 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Gary Weatherall | 01 mars 2021 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 17 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mrs Diane Compton | 01 mars 2021 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 17 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Nigel Compton | 01 mars 2021 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 17 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mrs Ann Toni Young | 01 mars 2021 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 17 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mrs Linda Weaver | 01 mars 2021 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 17 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Robert James Field | 22 févr. 2019 | 27 New Dover Road CT1 3DN Canterbury Camburgh House Kent United Kingdom | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Terrence John Young | 22 févr. 2019 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr David Rose | 06 avr. 2016 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Ian Samuel James Mitchell | 06 avr. 2016 | Weatherall Close Dunkirk ME13 9UL Faversham 19 England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0