INN PARTNERSHIP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINN PARTNERSHIP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03538785
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    • Vente au détail de boissons en magasin spécialisé (47250) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INN PARTNERSHIP ESTATES LIMITED 07 sept. 199807 sept. 1998
    DE FACTO 714 LIMITED01 avr. 199801 avr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 avr. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2024

    9 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2023

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    État du capital au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account canelled/amount credited to profit and loss reserves 09/03/2023
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of directors/ change of registered address 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    8 pagesMA

    Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 15 août 2021

    19 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge 2

    2 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 16 août 2020

    4 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritish299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627780001
    BRAMALL, Colin Stephen
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    British62475470002
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    DEEGAN, Jayne
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    Secrétaire
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    British94870790001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    British15541980001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488310001
    LYTHGOE, John Stephen
    89 Barley Road
    Thelwall
    WA4 2NF Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    89 Barley Road
    Thelwall
    WA4 2NF Warrington
    Cheshire
    British72341030001
    MILLER, Nicola Jane
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    Secrétaire
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    British95390370001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624390001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secrétaire désigné
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BRAMALL, Colin Stephen
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    British62475470002
    BRIGHT, John William
    Lower Mill
    Cuddington Lane Cuddington
    CW8 2SQ Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Lower Mill
    Cuddington Lane Cuddington
    CW8 2SQ Northwich
    Cheshire
    British76489540001
    CLAY, Hugh Edward
    Moorgarth Moorside Road
    Brookhouse
    LA2 9PN Lancaster
    Lancashire
    Administrateur
    Moorgarth Moorside Road
    Brookhouse
    LA2 9PN Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritish95074560001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish1812400001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DARESBURY, Peter Gilbert, Lord
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    Administrateur
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    EnglandBritish5404190003
    DODD, Gervase Paul Chandler
    Alvanley Hall
    Manley Road Alvanley
    WA6 9DN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Alvanley Hall
    Manley Road Alvanley
    WA6 9DN Warrington
    Cheshire
    British60382900001
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    DUNSTAN, Jennifer Anne
    24 Anhalt Road
    SW11 4NX London
    Administrateur
    24 Anhalt Road
    SW11 4NX London
    EnglandBritish61818060002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    GRANT, Martin James
    Oak House
    Waverley Edge
    CV8 3LW Bubbenhall
    Warwickshire
    Administrateur
    Oak House
    Waverley Edge
    CV8 3LW Bubbenhall
    Warwickshire
    UkBritish82731440001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    HANDS, Guy
    Colne House 89 Kippington Road
    TN13 2LW Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Colne House 89 Kippington Road
    TN13 2LW Sevenoaks
    Kent
    British2519120001
    HOWES, Lewis
    3 Webster Close
    GU22 0LR Woking
    Surrey
    Administrateur
    3 Webster Close
    GU22 0LR Woking
    Surrey
    American-Uk62776210002
    KING, Brian
    10 Blenheim Close
    CH5 3SJ Deeside
    Clwyd
    Administrateur
    10 Blenheim Close
    CH5 3SJ Deeside
    Clwyd
    British62427980001
    LONGDEN, John David
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish40890250001
    LYTHGOE, John Stephen
    89 Barley Road
    Thelwall
    WA4 2NF Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    89 Barley Road
    Thelwall
    WA4 2NF Warrington
    Cheshire
    British72341030001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INN PARTNERSHIP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3680937
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    INN PARTNERSHIP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 sept. 2025Due to be dissolved on
    27 mars 2023Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0