HCSU26 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HCSU26 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03542901 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HCSU26 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Chiltern House Garsington Road Cowley OX4 2PG Oxford England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HCSU26 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HCSU26 LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour HCSU26 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unipart House Cowley Oxford OX4 2PG à Chiltern House Garsington Road Cowley Oxford OX4 2PG le 20 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Amanda Jane Wyner en tant qu'administrateur le 31 oct. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Royston Hopper en tant que directeur le 31 oct. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed surepart svg LIMITED\certificate issued on 10/05/13 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2006 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HCSU26 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMMER, Michael Douglas | Secrétaire | 32 Watling Lane Dorchester On Thames OX10 7JG Wallingford Oxfordshire | British | 48355360001 | ||||||
| DESSAIN, Paul Mark | Administrateur | 10 High Street Bodicote OX15 4BX Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 17182840001 | |||||
| MOURGUE, Anthony John | Administrateur | Brompton Gates 170 Burley Road BH23 8DE Bransgore Dorset | England | British | 17182830005 | |||||
| WYNER, Amanda Jane | Administrateur | Garsington Road Cowley OX4 2PG Oxford Chiltern House England | England | British | 115512420001 | |||||
| CLARKE, Joanna Lindsey | Secrétaire | 10 Gordon Road Harborne B17 9HB Birmingham West Midlands | British | 68391410001 | ||||||
| STAMP, Christopher David | Secrétaire | 49 Grange Road Dorridge B93 8QS Solihull West Midlands | British | 44492580001 | ||||||
| CLARKE, Joanna Lindsey | Administrateur | 10 Gordon Road Harborne B17 9HB Birmingham West Midlands | British | 68391410001 | ||||||
| DESSAIN, Paul Mark | Administrateur | 10 High Street Bodicote OX15 4BX Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 17182840001 | |||||
| FISHER, Jacqueline | Administrateur désigné | 926 Kingstanding Road B44 9NG Birmingham West Midlands | British | 900013260001 | ||||||
| FORMAN, Paul Anthony | Administrateur | Millfield Coln St Aldwyns Post Office GL7 5AN Cirencester Gloucestershire | British | 59639890001 | ||||||
| GOODEY, Nigel | Administrateur | 7 Yarnells Hill OX2 9BD Oxford Oxfordshire | Scotland | British | 56600230001 | |||||
| HEALEY, John Joseph | Administrateur | 38 Elizabeth Jennings Way OX2 7BN Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 48355090002 | |||||
| HOPPER, Michael Royston | Administrateur | Binn End Sibford Gower OX15 5RQ Banbury Oxfordshire | England | British | 17182820001 | |||||
| ROBERTS, Peter Tregarthen | Administrateur | The Cottage Waldley Doveridge DE6 5LR Ashbourne Derbyshire | England | British | 55406540001 | |||||
| SCOTT, Christopher George | Administrateur | 120 Lady Byron Lane Knowle B93 9BA Solihull West Midlands | England | British | 94183390001 | |||||
| TONKS, Steve | Administrateur | 1 Stable Close Finmere MK18 4AD Buckingham Buckinghamshire | British | 64091350001 | ||||||
| WRAGG, James Philip | Administrateur | The Old Vicarage CV35 0HD Gaydon Warwickshire | British | 77836880001 |
HCSU26 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Second floating charge | Créé le 19 déc. 2003 Livré le 07 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and each other company named therein to the secured parties or any of them under or pursuant to the asset ancillary agreements and/or the charge | |
Brèves mentions By way of second floating charge its undertaking and all its property assets and rights including its property situated in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Non-vesting debts charge and first floating charge | Créé le 19 déc. 2003 Livré le 23 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all those of its present and future debts together with the related rights. By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge and guarantee | Créé le 12 avr. 2001 Livré le 25 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of each obligaor to any lender under each finance document which such obligor is a party and tmi under the isda master agreement dated 18TH october 1999 (all terms as defined) | |
Brèves mentions Floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge and guarantee | Créé le 29 sept. 1999 Livré le 14 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any transaction party under each transaction document to which such obligor is a party | |
Brèves mentions By way of a floating charge all its assets except for those contracts, to which it is a party, which by their terms prohibit the creation of a floating charge over or in respect of them. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0