MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACHIN YORKSHIRE LAMB LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03546111
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Adresse du siège social
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLARINE LIMITED15 avr. 199815 avr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2019

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2016

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 avr. 2016

    État du capital au 20 avr. 2016

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2015

    État du capital au 29 avr. 2015

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2014

    État du capital au 22 avr. 2014

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Edward Machin le 15 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MACHIN, Wendy Elizabeth
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Secrétaire
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    British41134850001
    MACHIN, Richard Edward
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    EnglandBritish19957810001
    EVANS, Roger David Loveden
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    British31795090001
    MACHIN, Richard Edward
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    British19957810001
    TURNER, Paul Robert
    9 Swainsea Lane
    YO18 8NE Pickering
    North Yorkshire
    Secrétaire
    9 Swainsea Lane
    YO18 8NE Pickering
    North Yorkshire
    British26819050002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    EVANS, Roger David Loveden
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish31795090001
    HAWORTH, Peter
    Newstead Grange
    Thirsk Road
    YO6 3NH Easingwold
    North Yorkshire
    Administrateur
    Newstead Grange
    Thirsk Road
    YO6 3NH Easingwold
    North Yorkshire
    United KingdomBritish58835860001
    MACHIN, John Parkin
    West Lodge
    Brandsby
    YO6 4RH York
    North Yorkshire
    Administrateur
    West Lodge
    Brandsby
    YO6 4RH York
    North Yorkshire
    British20027310001
    SIDAWAY, Paul
    2 Hengell
    Uchaf New Road
    SA45 9SE New Quay
    Ceredigion
    Administrateur
    2 Hengell
    Uchaf New Road
    SA45 9SE New Quay
    Ceredigion
    British100271160001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Richard Edward Machin
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Low Farm
    North Yorkshire
    England
    15 avr. 2016
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Low Farm
    North Yorkshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 21.4 acres of land or thereabouts at bradsby north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 09 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a thornhill farm and land at brandsby in the county of north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 10 mai 2006
    Livré le 13 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    2 x evaporator type no. SOP0019779; 2 x evaporator type no. SOP0019772; 2 evaporator type no. SOP0019773 (for details of further items charged please refer to form 395) together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging to the items listed.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H seaves farm, low farm, water end, mill hill farm, brandsby mill land and buildings on the north side of brandsby bank, home farm, spellar park and land and buildings adjoining brandsby t/no P43500.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton on swale to carlton minuat, busby stoop and knackers yard busby stoop t/nos NYK70514, NYK164481 and NYK267852.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H west lodge town street brandsby t/no YK877.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the west side of jail lane stearsby and land lying to the east of low farm brandsby york t/nos NYK265447 & NYK265448.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 juin 2004
    Livré le 23 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 23 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Knackers yard busby stoop thirsk north yorkshire t/n NYK164481. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 20 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Knackers yard busby stoop thirsk north yorkshire NYK164481. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 2003
    Livré le 17 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton-on-swale to carlton miniott busby stoop thirsk hambleton north yorkshire title number NYK267852. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2002
    Livré le 01 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Wenvoe busby stoop thirsk north yorkshire YO7 4EH.
    Personnes ayant droit
    • Robert Edgar Hawken and Kathleen Mary Hawken
    Transactions
    • 01 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 janv. 2000
    Livré le 20 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a the abattoir busby stoop nr thirsk north yorkshire. T/no. NYK70514. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 mai 1999
    Livré le 27 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 1998
    Livré le 18 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal sum of £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton-on-swale to carlton miniott busby stoop.t/no.NYK70514.
    Personnes ayant droit
    • Abbeyville Associates Limited
    Transactions
    • 18 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0