OFFICE METRO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOFFICE METRO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03548821
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OFFICE METRO LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe OFFICE METRO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    Berkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OFFICE METRO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REGUS LIMITED01 déc. 200301 déc. 2003
    REGUS PLC.18 juil. 200018 juil. 2000
    REGUS BUSINESS CENTRES PLC24 juin 199824 juin 1998
    TRUSHELFCO (NO.2348) LIMITED17 avr. 199817 avr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de OFFICE METRO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour OFFICE METRO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Douglas Francis Sutherland en tant que directeur le 10 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Leslie James Dixon en tant que directeur le 10 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Drive Chertsey Surrey KT16 0RS le 05 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2012

    État du capital au 06 juin 2012

    • Capital: GBP 12,500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Leslie James Dixon le 21 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paulo Henrique Dias le 01 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Règlements CE sur le début de l'insolvabilité

    75 pagesEC REGS D

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Leslie James Dixon le 21 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paulo Henrique Dias le 01 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Statuts

    31 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    legacy

    5 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Lynsey Blair en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paulo Henrique Dias le 07 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Douglas Francis Sutherland le 07 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Lynsey Ann Blair le 07 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Statuts

    33 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de OFFICE METRO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DIAS, Paulo Henrique
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    Berkshire
    United Kingdom
    SwitzerlandFrenchChief Executive Officer134293980003
    BLAIR, Lynsey Ann
    Boulevard Royal
    2449 Luxembourg
    26
    Luxembourg
    Secrétaire
    Boulevard Royal
    2449 Luxembourg
    26
    Luxembourg
    British134294000002
    LOBO, Rudolf John Gabriel
    Oakwood
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    Secrétaire
    Oakwood
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    British98891900001
    REGAN, Timothy Sean James Donovan
    The White Cottage
    High Street Nether Wallop
    SO20 8EZ Stockbridge
    Hampshire
    Secrétaire
    The White Cottage
    High Street Nether Wallop
    SO20 8EZ Stockbridge
    Hampshire
    British67766590007
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    DIXON, Mark Leslie James
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    Berkshire
    United Kingdom
    MonacoBritishDirector64649350028
    GLEADLE, Stephen Derrick
    Hillview House
    Cokes Lane
    HP8 4TA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hillview House
    Cokes Lane
    HP8 4TA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    UkBritishDirector182995980001
    GRAY, George Gowans, Dr
    19 Lakeside Grange
    KT13 9ZE Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    19 Lakeside Grange
    KT13 9ZE Weybridge
    Surrey
    BritishDirector11525130002
    JENKINS, Peter Lewis
    50 Beaconsfield Road
    TW1 3HU Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    50 Beaconsfield Road
    TW1 3HU Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishDirector68706630001
    KUIJPERS, Robert Marnix
    Les Qares
    Rue Du Try-Au-Chene
    FOREIGN Bowsval 1470
    Belgium
    Administrateur
    Les Qares
    Rue Du Try-Au-Chene
    FOREIGN Bowsval 1470
    Belgium
    DutchDirector66675110001
    LOBO, Rudolf John Gabriel
    Oakwood
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Oakwood
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    BritishDirector98891900001
    MARCUS, Ian
    46 Royston Park Road
    HA5 4AF Hatch End
    Middlesex
    Administrateur
    46 Royston Park Road
    HA5 4AF Hatch End
    Middlesex
    BritishBanker85847920001
    MATTHEWS, John Waylett
    Limpley Crest Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA2 7GW Bath
    Avon
    Administrateur
    Limpley Crest Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA2 7GW Bath
    Avon
    EnglandBritishCompany Director28826190001
    ORF, Roger Gerard
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    Administrateur
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    United KingdomBritishDirector38079110001
    REID, Timothy Mark
    Flat 6 42 Blenheim Crescent
    W11 1NY London
    Administrateur
    Flat 6 42 Blenheim Crescent
    W11 1NY London
    New ZealandSolicitor57566350001
    ROBINSON, Anthony Martin
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector55873860003
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    51 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    Administrateur
    51 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    BritishSolicitor77049790001
    RYDE, Andrew Gareth
    Dell Lodge Pinewood Close
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Dell Lodge Pinewood Close
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    BritishSolicitor47612540002
    STAMP, Stephen Antony
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    BritishDirector38572920003
    SUTHERLAND, Douglas Francis
    Rue Joseph Tockert
    Luxembourg
    12
    L-2620
    Luxembourg
    Administrateur
    Rue Joseph Tockert
    Luxembourg
    12
    L-2620
    Luxembourg
    LuxembourgAmericanIndependent Consultant134293920002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary61053330001

    OFFICE METRO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 19 janv. 2011
    Livré le 26 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts now and in the future credited to account number 84098309 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Commercial pledge agreement
    Créé le 20 août 2004
    Livré le 03 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from regus corporation (the "borrower") to the agent and to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgor acting jointly and severally with the co-pledgor, undertook to pay the agent and to the lenders the amount of the secured obligations on the respective date due thereof;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bear Stearns Corporate Lending Inc (The Pledgee or the Agent)
    Transactions
    • 03 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 08 juil. 2002
    Livré le 13 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation no 65749952 and 09033009 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 07 janv. 2002
    Livré le 14 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designations 65747526 and 0015687 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balance
    Créé le 09 oct. 2001
    Livré le 29 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a guarantee facility agreement dated 26 september 2001
    Brèves mentions
    All sums from time to time standing to the credit of the customers deposit account open or to be opened in the banks books including any sub-account and redesignation of that account and any account substituted for it.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London
    Transactions
    • 29 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 04 oct. 2000
    Livré le 25 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of hewlett packard for £3,000,000
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the sum of £3,000,000 held by the bank on an account numbered 65731611 earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 16 juin 2000
    Livré le 30 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a standby letter of credit in favour of bank of tokyo mitsubishi limited for £1,156,050.60
    Brèves mentions
    The sum of £1,156,050.60 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65723759 and earmarked or desinated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 24 févr. 2000
    Livré le 07 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a standby letter of credit in favour of the bank of tokyo mitsubishi for 150,000,000 japenese yen
    Brèves mentions
    The sum of £846,548.90 and interest accrued now or to be held by the bank on account number 65723759.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 25 nov. 1999
    Livré le 08 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a standby letter of credit dated 22 october 1998 for 1,921,180,000 japanese yen in favour of standard chartered bank
    Brèves mentions
    The sum of £10,309,928 and interest accrued now or to be held by the bank on an account numbreed 65706250.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 14 sept. 1999
    Livré le 04 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a standby letter of credit in favour of standard chartered bank dated 22 october 1998 for 1,819,180,000 japanese yen
    Brèves mentions
    The sum of £9,709,928 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65706250 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 02 sept. 1999
    Livré le 09 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a standby letter of credit in favour of standard chartered bank for 1,469,180,000 japanese yen
    Brèves mentions
    The sum of £7,732,526 together with interst accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65706250 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 22 juil. 1999
    Livré le 29 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a standby letter of credit dated 22 october 1998 for 1,429,180,000 japanese yen in favour of standard chartered bank
    Brèves mentions
    £7,522,000 and interest accrued now or to be held by the bank on account number 65706250.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 17 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a standby letter of credit in favour of standard chartered bank for 1,381,680,000 japanese yen
    Brèves mentions
    The sum of £7,272,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65706250 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 22 janv. 1999
    Livré le 01 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £5,472,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65706250 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 22 oct. 1998
    Livré le 02 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a standby letter of credit dated 22ND october 1998 in favour of standard chartered bank for £5,472,000.00
    Brèves mentions
    The sum of £4,104,000.00 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 65706250 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0