WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED

WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03549059
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hesketh Mont
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOBILECHAIN LIMITED20 avr. 199820 avr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Adrian John Bennett en tant qu'administrateur le 16 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 035490590021, créée le 06 déc. 2024

    6 pagesMR01

    Modification des détails de Mrs Sarah Amy Mcnally en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juil. 2024

    2 pagesPSC04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Sarah Amy Mcnally le 30 août 2024

    2 pagesCH01

    Cessation de Bradley John Edward Ridgewell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2024

    1 pagesPSC07

    Cessation de Laura Pamela Bennett en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2024

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Ms Sarah Amy Mcnally en tant qu'administrateur le 01 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bradley John Edward Ridgewell en tant que directeur le 30 juin 2024

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 035490590020 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes de micro-entité établis au 30 déc. 2023

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 déc. 2022

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 035490590020, créée le 21 juil. 2022

    34 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 20-22 Wenlock Road London N1 7GU England à Hesketh Mont Lord Street Southport PR8 1JR le 11 juil. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes complets avec exemption totale modifiés jusqu'au 30 déc. 2021

    14 pagesAAMD

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 déc. 2021

    9 pagesAA

    Notification de Bradley John Edward Ridgewell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2022

    2 pagesPSC01

    Nomination de Mr Bradley John Edward Ridgewell en tant qu'administrateur le 01 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Adrian John Bennett en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de Adrian John Bennett en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2021

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Sarah Amy Mcnally en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENNETT, Adrian John
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Administrateur
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    EnglandBritishDirector330413020001
    MCNALLY, Sarah Amy
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Administrateur
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    United KingdomBritishDirector324802150002
    ANSELL, Hazel
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    Secrétaire
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    158468140001
    BENNETT, Adrian John
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    Secrétaire
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    BritishDirector86675600001
    BENNETT, Adrian John
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    Secrétaire
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    BritishDirector86675600001
    BENNETT, Joan Carol
    23 Piercefield Road
    Formby
    L37 7DG Liverpool
    Secrétaire
    23 Piercefield Road
    Formby
    L37 7DG Liverpool
    BritishAdministrator35641510002
    WAGGETT, Suzanne
    61 Hartwood Road
    PR9 9AW Southport
    Secrétaire
    61 Hartwood Road
    PR9 9AW Southport
    British86675730003
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Secrétaire désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BENNETT, Adrian John
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    Administrateur
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    United KingdomBritishDirector249337210001
    BENNETT, Adrian John
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    Administrateur
    Phillipstockstraat 23/25
    Brugge
    8000
    Belgium
    BelgiumBritishCompany Director86675600001
    BENNETT, Joan Carol
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    Administrateur
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    EnglandBritishCompany Director35641510002
    BENNETT, Joan Carol
    23 Piercefield Road
    Formby
    L37 7DG Liverpool
    Administrateur
    23 Piercefield Road
    Formby
    L37 7DG Liverpool
    EnglandBritishAdministrator35641510002
    MCNALLY, Sarah Amy
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    Administrateur
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    United KingdomBritishDirector171591640003
    RIDGEWELL, Bradley John Edward
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Administrateur
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    EnglandBritishDirector285672800001
    URQUHART, Suzanne
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    Administrateur
    Hesketh Mount, 92-96 Lord Street
    Southport
    PR8 1JR Merseyside
    EnglandBritishDirector86675730005
    URQUHART, Suzanne
    The Bales
    2a The Grange
    PR9 7NZ Southport
    Administrateur
    The Bales
    2a The Grange
    PR9 7NZ Southport
    BritishProperty Development86675730001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Administrateur désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Bradley John Edward Ridgewell
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    01 janv. 2022
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Adrian John Bennett
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    29 mars 2019
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Ms Laura Pamela Bennett
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    01 juin 2016
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mrs Suzanne Urquhart
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    01 juin 2016
    Wenlock Road
    N1 7GU London
    20-22
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Sarah Amy Mcnally
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    01 juin 2016
    Lord Street
    PR8 1JR Southport
    Hesketh Mont
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WORKSHARP (PROPERTIES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 06 déc. 2024
    Livré le 09 déc. 2024
    En cours
    Brève description
    Freehold property known as hesketh mount, lord street, southport, PR8 1JR, being all of the land and buildings in title MS313776. Freehold property known as 27A banastre road, southport, PR8 5AW, being all of the land and buildings in title MS326852, for furhter details of properties charged, please refer to the instrument, including all buildings, fixtures and fittings, the related rights and the goodwill.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shawbrook Bank Limited
    Transactions
    • 09 déc. 2024Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 21 juil. 2022
    Livré le 03 août 2022
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Contains fixed charge. Contains floating charge. Floating charge covers all the property or undertaking of the company. Contains negative pledge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Loan and Equity Fund LLP
    Transactions
    • 03 août 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 juil. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 mai 2017
    Livré le 21 mai 2017
    En cours
    Brève description
    All that leasehold property known as flat 3 park court park road southport merseyside registered at the land registry under title number LA33293.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 21 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 mai 2017
    Livré le 21 mai 2017
    En cours
    Brève description
    All that freehold land and buildings known as 27A banastre road southport merseyside registered at the land registry under title number MS326852.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbaken Ab (Publ)
    Transactions
    • 21 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 mars 2017
    Livré le 09 mars 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 09 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    Mortgage
    Créé le 02 févr. 2012
    Livré le 03 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 85 sandon road, southport, merseyside t/no MS442164 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 19 juil. 2011
    Livré le 26 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a 3 grove terrace, southport, merseyside t/no MS378121 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 07 janv. 2010
    Livré le 09 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 27A banastre road southport merseyside t/no's MS326852 and MS409032 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 16 déc. 2008
    Livré le 05 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    92B lord street southport units 92, 94 & 96 hesketh mount lord street southport and 1A, 3, 3A and 3B market street southport all rents and licence fees moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 05 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 27 juin 2008
    Livré le 04 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    19 baillie street rochdale t/no. GM602404 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 04 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over account
    Créé le 10 janv. 2008
    Livré le 29 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies not exceeding £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All those monies held in the account.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 29 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2008
    Livré le 25 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Nonth floor apartment C9-2 great northern tower 1 watson street manchester t/no MAN78502. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2008
    Livré le 25 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    142A and 142B cambridge road southport t/no MS220562. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 sept. 2005
    Livré le 22 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings being 19 (alson k/a 19A and 19B) baillie street rochdale t/no GM602404, and 92-96B (even) lord street and 1-3B (odd) market street sefton merseyside (also k/a hesketh mount) t/no MS313776. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transactions
    • 22 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 19 a & b baillie street, rochdale, lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 142A and b cambridge road, churchtown, southport.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of shares
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 04 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All of the company's shares in the capital of mobilechain trinity court limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 04 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 2002
    Livré le 26 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 5 the avondale 62 the promenade southport merseyside PR9 0HZ all uncalled capital and any other freehold or leasehold property, book debts and other debts, floating charge over all the undertaking and goodwill of the company whatsoever and wheresoever.
    Personnes ayant droit
    • Paragon Mortgages Limited
    Transactions
    • 26 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    47 faulkland road, southport. All uncalled capital and any other f/h and l/h property. Book debts and other debts. Floating charge over the undertaking and goodwill of the company.
    Personnes ayant droit
    • Paragon Mortgages Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 12 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 euston street liverpool the rental income by way of first fixed charge..the property rights by way of first fixed charge and all of your undertaking and assets by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Paragon Mortgages Limited
    Transactions
    • 12 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 2001
    Livré le 21 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    47 heathfield drive brookfield preston all uncalled capital and any other f/h or l/h property book and other debts floating charge all the undertaking and goodwill of the company whatsoever and wheresoever.
    Personnes ayant droit
    • Paragon Mortgages Limited
    Transactions
    • 21 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0