THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED

THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 03558717
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Combined form b/z convert to rs
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    12 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 25/07/2018
    RES13

    Cessation de la nomination de John Philip Broadhead en tant que directeur le 21 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Angela Diane Mcclements en tant que directeur le 06 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    65 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Susan Lane en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Jones en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Mansell Whittingham en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Andrew Overton en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Niku Mawby en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Harry Claus Ireland en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Laura Irene Hilditch en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Desmond Gerard Hudson en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Angela Diane Mcclements en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Dickson en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Philip Broadhead en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Anne Marie Ward en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul David James Weston en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Deborah Pauline Griffiths en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Annette Marie Shipley en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Danielle Oum en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Esther Leonie Wright en tant qu'administrateur le 30 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 035587170011, créée le 02 oct. 2017

    33 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    60 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROGERSON, Catherine Maria
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Secrétaire
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    228916990001
    DICKSON, James
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishRetired125336660001
    ESIMAJE-HEATH, Jacqueline Aminioritse
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector Of Strategic Projects181062270001
    FISHER, Alison Jane
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishNon Exec180811350001
    GRIFFITHS, Deborah Pauline
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishConsultant214306390001
    HUDSON, Desmond Gerard
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director242664130001
    OUM, Danielle
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishNon Exec Director231209490001
    SHIPLEY, Annette Marie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishManaging Director242646700001
    WARD, Anne Marie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishChair154496190001
    WESTON, Paul David James
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishFinance Director61904620002
    WRIGHT, Esther Leonie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishDirector131462320002
    GILES, Karen Eileen
    29 Windsor Avenue
    E17 5NL London
    Secrétaire
    29 Windsor Avenue
    E17 5NL London
    British58123890001
    HORTON, Christopher John
    81 Compton Road
    WV3 9QH Wolverhampton
    Secrétaire
    81 Compton Road
    WV3 9QH Wolverhampton
    British37400090004
    MOORES, Christopher John
    14 Ragleth Road
    SY6 7BN Church Stretton
    Shropshire
    Secrétaire
    14 Ragleth Road
    SY6 7BN Church Stretton
    Shropshire
    British61381930001
    ALVEY, John Robert
    46 Haygate Road
    Wellington
    TF1 1QN Telford
    Salop
    Administrateur
    46 Haygate Road
    Wellington
    TF1 1QN Telford
    Salop
    BritishTeacher70857410001
    ATHERSMITH, Roy
    59 Ardern Avenue
    Dawley
    TF4 2AL Telford
    Salop
    Administrateur
    59 Ardern Avenue
    Dawley
    TF4 2AL Telford
    Salop
    BritishTelford Wrekin Counciller28998870001
    BARBER, John Walter
    32 Ercall View
    TF3 5AP Telford
    Salop
    Administrateur
    32 Ercall View
    TF3 5AP Telford
    Salop
    BritishRetired64656420001
    BARTLETT, Karl
    67 Jubilee Avenue
    Donnington
    TF2 8HR Telford
    Salop
    Administrateur
    67 Jubilee Avenue
    Donnington
    TF2 8HR Telford
    Salop
    BritishRoyal Mail72885770001
    BEST, Francis Paul
    April Cottage
    Ford Heath
    SY5 9NW Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    April Cottage
    Ford Heath
    SY5 9NW Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishFinance Director73448600001
    BROADHEAD, John Philip
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishChief Executive242649380001
    BROTHERTON, Margaret Ann (Margo)
    18 Adams Crescent
    TF10 7QJ Newport
    Salop
    Administrateur
    18 Adams Crescent
    TF10 7QJ Newport
    Salop
    EnglandBritishWaitress70541840002
    CHAVE, John Howard Benjamin
    32 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    Administrateur
    32 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    BritishSolicitor57774160002
    CLAYTON, John Anthony
    The Higher House
    Grinshill
    SY4 3BN Shrewsbury
    Administrateur
    The Higher House
    Grinshill
    SY4 3BN Shrewsbury
    EnglandBritishChartered Surveyor12135130003
    COPSON, Andrew Nicholas
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishProperty Developer122559290001
    COPSON, Andrew Nicholas
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishConsultant122559290001
    CRUISE, Celia
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishRetired Secretary182385340001
    DAVIS, Ian Martin Kitredge
    34 Raynham Street
    SG13 7DE Hertford
    Herts
    Administrateur
    34 Raynham Street
    SG13 7DE Hertford
    Herts
    BritishSolicitor57774150001
    DUCE, Jeremy Charles Stephen
    10 Regent Square
    Madeley
    TF7 5EA Telford
    Shropshire
    Administrateur
    10 Regent Square
    Madeley
    TF7 5EA Telford
    Shropshire
    BritishRetired78370270001
    EADE, Andrew John
    Rowton Stables
    Rowton
    TF6 6QY Telford
    Shropshire
    Administrateur
    Rowton Stables
    Rowton
    TF6 6QY Telford
    Shropshire
    BritishCompany Director43091790004
    ELDRIDGE, George Donald
    18 Withington Close
    Oakengates
    TF2 6JR Telford
    Salop
    Administrateur
    18 Withington Close
    Oakengates
    TF2 6JR Telford
    Salop
    BritishRetired62638040001
    FLETCHER, Ian Thomas Wells
    67 Derwent Drive
    Priorslee
    TF2 9QR Telford
    Shropshire
    Administrateur
    67 Derwent Drive
    Priorslee
    TF2 9QR Telford
    Shropshire
    EnglandBritishBusiness Analyst59199820001
    FLINT, Susan Pamela
    28 Wordsworth Way
    Priorslee
    TF2 9RW Telford
    Shropshire
    Administrateur
    28 Wordsworth Way
    Priorslee
    TF2 9RW Telford
    Shropshire
    BritishSelf Employed55708270001
    FLOYD, Robert Glen
    5 Berrystead
    CW8 1NG Hartford
    Cheshire
    Administrateur
    5 Berrystead
    CW8 1NG Hartford
    Cheshire
    EnglandBritishConsultant80471840001
    GARBETT, Peter Robert
    37 Trinity Road
    Dawley
    TF4 3EW Telford
    Salop
    Administrateur
    37 Trinity Road
    Dawley
    TF4 3EW Telford
    Salop
    BritishCarer61382830001
    GWYNNE, Jean
    38 Meadow Road
    TF10 7TH Newport
    Salop
    Administrateur
    38 Meadow Road
    TF10 7TH Newport
    Salop
    BritishHousewife61382680001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Wrekin Housing Group Limited
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    The Wrekin Housing Trust
    England
    06 avr. 2016
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    The Wrekin Housing Trust
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Guarantee
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement5032634
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 oct. 2017
    Livré le 10 oct. 2017
    En cours
    Brève description
    9 dorran place, st georges, as registered at the land registry (title number SL119848 and SL119846) for further details please see schedule 1 of the legal mortgage.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 10 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 nov. 2016
    Livré le 04 nov. 2016
    En cours
    Brève description
    Unit 5, stirchley district centre, stirchley, telford, TF3 1ET (registered at the land registry with title number SL238150). For more details please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2016
    Livré le 09 mars 2016
    En cours
    Brève description
    1 athersmith close title number SL117391. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 09 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 déc. 2015
    Livré le 04 janv. 2016
    En cours
    Brève description
    The freehold property being 2 bower form drive, st martins, registered at the land registry under title number SL231484. Please refer to schedule 1 of the legal mortgage for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 04 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 02 nov. 2015
    Livré le 05 nov. 2015
    En cours
    Brève description
    The freehold property being 1 balmoral court, captain webb drive registered at the land registry under title number SL206751. Please refer to schedule 1 of the fixed charge for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 05 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Fixed charge
    Créé le 29 mars 2012
    Livré le 05 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    SL26279 43 south drive madeley telford, SL183575 33 the smithfields newport, SL44624 155 willowfield woodside telford, for further details of properties charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 05 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Form of fixed charge
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the property together with all the buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale.all plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 05 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All of the obligations which the company may at any time have to the chargee (whether for its own account or as agent and trustee for the secured parties or any of the secured parties pursuant to a loan facility agreement each certificate of novation effected pursuant to the provisions of the said loan facility agreement a letter of agreement relating to the day to day banking facilities including overdraft and settlement limits any fixed floating charge or account charge or any other document creating evidencing or granting security entered into by the company and/or in favour of the chargee pursuant to the provisions of the said loan facility agreement dated 25 march 1999 (all terms defined)
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all that leasehold property known as the wrekin head office, colliers way, old park, telford, shropshire pursuant to the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society in Its Own Capacity Os Arranger and Lender Andas Agent and Trustee for National Westminster Bank PLC in Its Capacity as Agent, Arranger and Lender and Barclays Bank PLC, Abbey National Treasury Service PLC and Britannia Building Society
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge between the company and nationwide building society as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined)
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities owed by the borrower to each finance party under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities")
    Brèves mentions
    By way of first fixed legal mortgage all the property referred to in schedule 1 together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale of all or any part thereof and (so far as the same are capable of being mortgaged) the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the borrower and any monies paid or payable in respect of such covenants;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Account charge
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under this charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities")
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of: (a) the proceeds account; and (b) the sinking fund and the debts represented thereby.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0