SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 03562448 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Adresse du siège social | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr James Lawrence Rember en tant qu'administrateur le 08 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher David Pinney en tant que directeur le 12 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Statuts | 26 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Sedgwick Uk Holdings Ii Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mai 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 60 Fenchurch Street London EC3M 4AD England à 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD le 16 mai 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Christopher David Pinney en tant qu'administrateur le 22 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Victor Muress en tant que directeur le 22 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNER, John Edward | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | Irish | 183383870001 | |||||||||
| REMBER, James Lawrence | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 150168360001 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Secrétaire | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | British | 110877530002 | ||||||||||
| JENNER, John Edward | Secrétaire | 53 Blackmores Grove TW11 9AE Teddington Middlesex | Irish | 66166470002 | ||||||||||
| LI, Mei Ching | Secrétaire | 9 Queen Annes Gate Caversham RG4 5DU Reading Berkshire | British | 104874210001 | ||||||||||
| RYNHOUD, John Gregory | Secrétaire | Cheshire Park Warfield RG42 3XA Bracknell 18 Berkshire | British | 111493000002 | ||||||||||
| SALSBERG, Eric Paul | Secrétaire | 1 Carnwath Crescent Willowdale Ontario M2p 1j4 Canada | Canadian | 64465570001 | ||||||||||
| SUTTON, Jonathan | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | 215488070001 | |||||||||||
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED | Secrétaire | Bank Street Level 29 E14 5DS London 40 England |
| 216788570001 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| BENTLEY, Nicholas Craig | Administrateur | 13 Montpelier Crescent BN1 3JF Brighton East Sussex | British | 70198930005 | ||||||||||
| BES, Philippe | Administrateur | C/O Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading Berkshire | United Kingdom | French | 56197940004 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Administrateur | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | United Kingdom | British | 110877530002 | |||||||||
| BRYANT, Esther Julie | Administrateur | 4 Abbots Close GU51 3RF Fleet Hampshire | British | 72784050003 | ||||||||||
| CHOU, Francis | Administrateur | 70 Dragoon Cresent Scarborough Ontario M1v 1n4 Canada | Canadian | 64826160001 | ||||||||||
| CHRISTIANSEN, Jan | Administrateur | 20877 Wildrose Drive 60010 Barrington 60010 Illinois Usa | United States | Danish | 102230030001 | |||||||||
| DI CICCO, Domenick C. | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United States | American | 207059350001 | |||||||||
| FRITZE, Peter Kurt | Administrateur | 550 Front St West Ph \16 Toronto M5v 3n5 Canada | Canadian | 98724190001 | ||||||||||
| GRANT, Alexander James | Administrateur | Slade The Heath Dedham CO7 6BU Colchester Essex | United Kingdom | British | 23211410001 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Administrateur | C/O Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading Berkshire | United Kingdom | Irish | 66166470002 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Administrateur | 53 Blackmores Grove TW11 9AE Teddington Middlesex | United Kingdom | Irish | 66166470002 | |||||||||
| MULLEN, Edmund | Administrateur | C/O Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading Berkshire | Usa | Irish | 126318250001 | |||||||||
| MURESS, Ian Victor | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United Kingdom | British | 107295730001 | |||||||||
| ODEDRA, Meera | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 207219690001 | |||||||||
| PINNEY, Christopher David | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 158868090001 | |||||||||
| POLLEY, Kenneth Richard | Administrateur | 7102 Doral Place Tyler FOREIGN Texas 75703 Usa | Canadian | 64392760001 | ||||||||||
| RAPER, Stephen | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 259503170001 | |||||||||
| ROIBAS, Ferdinand | Administrateur | 1847 Raveneaux Lane Tyler Smith County Texas 75703 Usa | Canadian | 64392830001 | ||||||||||
| RYNHOUD, John Gregory | Administrateur | Cheshire Park Warfield RG42 3XA Bracknell 18 Berkshire | England | British | 111493000002 | |||||||||
| SALSBERG, Eric Paul | Administrateur | 1 Carnwath Crescent Willowdale Ontario M2p 1j4 Canada | Canadian | 64465570001 | ||||||||||
| SUTTON, Jonathan Guy | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 215482550001 | |||||||||
| TUBB, Elizabeth Janet Mary | Administrateur | C/O Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading Berkshire | United Kingdom | British | 162278590001 | |||||||||
| WATSA, Vivian Prem | Administrateur | 21 Douglas Drive Toronto M4w 2b2 FOREIGN Ontario Canada | Canadian | 58930630001 | ||||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEDGWICK MORDEN ACQUISITIONS ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick Uk Holdings Ii Limited | 06 avr. 2016 | Fenchurch Street EC3M 3BD London Sedgwick, 30 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0