WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03576124 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?
Adresse du siège social | 93 Queen Street S1 1WF Sheffield South Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 27 mars 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 14 pages | 4.72 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 août 2012 | 14 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 93 Queen Street Sheffield South Yorkshire S1 1WF England le 18 août 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 5 pages | 4.20 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Parkway Avenue Sheffield S9 4UL le 07 juil. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 27 mars 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 mars 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 mars 2008 | 17 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 8 pages | 395 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Comptes annuels établis au 01 avr. 2006 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 403a | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 7 pages | 395 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 02 avr. 2005 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b |
Qui sont les dirigeants de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUGHTON, Michael Barry | Secrétaire | 8 The Old Saw Mill Cowling BD22 0JT Keighley West Yorkshire | British | Accountant | 109567330001 | |||||
COOK, Andrew John, Sir | Administrateur | Reduit Le Variouf Forest GY8 0BH Guernsey Channel Islands | England | British | Chairman | 102659430002 | ||||
GRAYLEY, Kevin John | Administrateur | Dove Cottage 23 Mill Farm Drive Newmillerdam WF2 6QP Wakefield West Yorkshire | England | British | Managing Director | 43273780002 | ||||
AUSTIN, John Alan | Secrétaire | 1 Hollincross Lane SK13 8JQ Glossop Derbyshire | British | Accountant | 99402330001 | |||||
BARTLE, Thomas | Secrétaire | 18 Ringwood Way Hemsworth WF9 4HZ Pontefract West Yorkshire | British | Accountant | 79918800001 | |||||
CALDWELL, John Christopher | Secrétaire | 282 Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | British | Director | 83552520001 | |||||
COOK, David Laurence | Secrétaire | 30 Hargreaves Close Morley LS27 9TE Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 92183980001 | |||||
MOORE, Peter John | Secrétaire | Flat 3 Osborne Court 154 Osborne Road S11 9BB Sheffield | British | Accountant | 43273740002 | |||||
UPRICHARD, Andrew | Secrétaire désigné | 1 Alexandra Road SK17 9NQ Buxton Derbyshire | British | 900006640001 | ||||||
BARTLE, Thomas | Administrateur | 18 Ringwood Way Hemsworth WF9 4HZ Pontefract West Yorkshire | British | Accountant | 79918800001 | |||||
CALDWELL, John Christopher | Administrateur | 282 Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | England | British | Director | 83552520001 | ||||
CLARK, Ross Mckenzie | Administrateur désigné | 15 Hall Farm Grove Hoylandswaine S36 7LJ Barnsley South Yorkshire | British | 900016690001 | ||||||
DEAN, David James | Administrateur | 15 Tremaine Close Hartside TS27 3LE Hartlepool Teeside | England | British | Manager | 90981030001 | ||||
KITE, Philip John | Administrateur | Garden House Town Farm NE43 7UL Newton Northumberland | United Kingdom | British | Managing Director | 43273920002 | ||||
MOORE, Peter John | Administrateur | Flat 3 Osborne Court 154 Osborne Road S11 9BB Sheffield | British | Accountant | 43273740002 | |||||
SIMKINS, Angela | Administrateur | Hambleton View Kirby Hill Boroughbridge YO51 9DS York | United Kingdom | British | Director | 60263960001 |
WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Créé le 29 janv. 2008 Livré le 08 févr. 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 29 juin 2006 Livré le 04 juil. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 août 2004 Livré le 27 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 17 août 2004 Livré le 26 août 2004 | En cours | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998) | Créé le 30 oct. 1998 Livré le 17 nov. 1998 | En cours | Montant garanti All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0