WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03576124
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WILLIAM COOK BLAIR MACHINE SHOP LIMITED29 oct. 199829 oct. 1998
    IMCO (1898) LIMITED04 juin 199804 juin 1998

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pages4.72

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 05 août 2011

    LRESEX

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 août 2012

    14 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 93 Queen Street Sheffield South Yorkshire S1 1WF England le 18 août 2011

    1 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de Parkway Avenue Sheffield S9 4UL le 07 juil. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2011

    État du capital au 07 juin 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 27 mars 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 28 mars 2009

    15 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 29 mars 2008

    17 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re guarnatee / debenture & intercreditior deed 29/01/2008
    RES13

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    8 pages395

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    17 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 01 avr. 2006

    17 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages395

    Comptes annuels établis au 02 avr. 2005

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOUGHTON, Michael Barry
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    BritishAccountant109567330001
    COOK, Andrew John, Sir
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    EnglandBritishChairman102659430002
    GRAYLEY, Kevin John
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director43273780002
    AUSTIN, John Alan
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    Secrétaire
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant99402330001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector83552520001
    COOK, David Laurence
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant92183980001
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Secrétaire
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    BritishAccountant43273740002
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secrétaire désigné
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector83552520001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British900016690001
    DEAN, David James
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    Administrateur
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    EnglandBritishManager90981030001
    KITE, Philip John
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    Administrateur
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    United KingdomBritishManaging Director43273920002
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Administrateur
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    BritishAccountant43273740002
    SIMKINS, Angela
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    Administrateur
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    United KingdomBritishDirector60263960001

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Cook Holdings Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 juin 2006
    Livré le 04 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Aj Cook Pension Scheme
    Transactions
    • 04 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 août 2004
    Livré le 27 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 27 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 17 août 2004
    Livré le 26 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Andrew John Cook Cbe (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 26 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998)
    Créé le 30 oct. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 janv. 2014Dissolved on
    05 août 2011Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    practitioner
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    practitioner
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0