RUSKIN CAMWAY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUSKIN CAMWAY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03582762
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sattago Cottage
    360a Brighton Road
    CR2 6AL Croydon
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALFORD PROPERTIES LIMITED17 juin 199817 juin 1998

    Quels sont les derniers comptes de RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2011

    10 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 1 Harestone Valley Road Caterham Surrey CR3 6HL le 06 juil. 2010

    2 pagesAD01

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution :- "Books,Records etc"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:special resolution "in specie"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 juin 2010

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 mai 2008

    17 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mai 2007

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages169

    Statuts

    3 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share buyback agreement 08/11/07
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'actions propres sur capital

    RES08

    Résolutions

    Resolutions
    12 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de RUSKIN CAMWAY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCEWAN, Ross
    54 Markfield Road
    CR3 6RN Caterham
    Surrey
    Secrétaire
    54 Markfield Road
    CR3 6RN Caterham
    Surrey
    BritishCompany Secretary82912960002
    HALL, Garry John
    34 Monkhams Drive
    IG8 0LE Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    34 Monkhams Drive
    IG8 0LE Woodford Green
    Essex
    EnglandBritishDirector60772660001
    KHOSHABA, Robert Kambar
    15 Harefield Road
    SL6 5EA Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    15 Harefield Road
    SL6 5EA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant5426120001
    MCEWAN, Ross
    54 Markfield Road
    CR3 6RN Caterham
    Surrey
    Administrateur
    54 Markfield Road
    CR3 6RN Caterham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary82912960002
    JACKSON, Andrew Kenneth Peter
    Hogshatch
    Penshurst
    TN11 8AS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Hogshatch
    Penshurst
    TN11 8AS Tonbridge
    Kent
    BritishChartered Accountant1479620001
    KHOSHABA, Dorothy Joan
    15 Harefield Road
    SL6 5EA Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Harefield Road
    SL6 5EA Maidenhead
    Berkshire
    British14160790001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Secrétaire désigné
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    COOMBS, Dennis Gordon
    3 The Beeches
    13 Wray Park Road
    RH2 0US Reigate
    Surrey
    Administrateur
    3 The Beeches
    13 Wray Park Road
    RH2 0US Reigate
    Surrey
    BritishDirector12398850004
    EVANS, David Gareth
    7 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Administrateur
    7 Mckay Road
    SW20 0HT London
    BritishMarketing Director1479630001
    JACKSON, Andrew Kenneth Peter
    Hogshatch
    Penshurst
    TN11 8AS Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Hogshatch
    Penshurst
    TN11 8AS Tonbridge
    Kent
    BritishChartered Accountant1479620001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Administrateur désigné
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    RUSKIN CAMWAY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 16 mars 2009
    Livré le 20 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £40,000 credited to account designation number 11083549 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 2006
    Livré le 27 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Nos 1,3 & 5 windmill lane epsom surrey t/nos SY120523, SY118336 & SY98451. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2006
    Livré le 04 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 5 windmill lane, epsom, surrey t/no SY98451. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 mars 2006
    Livré le 14 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 windmill lane, epsom, surrey t/no. SY118336. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 28 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,600,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The roebuck hotel buckhurst hill essex t/no EX354060. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Camway Properties Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The roebuck hotel buckhurst hill essex t/no EX354060. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juin 2004
    Livré le 25 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 30 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property shortly known as 255-265 kingston road wimbledon and registered at h m land registry under title numbers SGL317124 and SGL328233.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 21 nov. 2000
    Livré le 25 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,600,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Shell amen corner 187-191 mitcham road tooting.
    Personnes ayant droit
    • Camway Properties Limited
    Transactions
    • 25 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 2000
    Livré le 25 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Shell amen corner 187-191 mitcham road tooting.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 févr. 1999
    Livré le 04 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a clevehurst st georges avenue weybridge surrey t/no SY680728.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Transfer deed
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 28 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 due or to become due from the company to the chargee for each residential dwelling permitted by planning permission or planning permissions which exceeds a density of 12 residential dwellings obtained within 10 years of 8 january 1999
    Brèves mentions
    F/H property k/a clevehurst st georges avenue weybridge surrey t/n SY153700.
    Personnes ayant droit
    • Margaret Doreen Mcneill, Robin Anthony Birch, Margaret Ann Birch, Timothy Thomas Jones,Mark Andrew Perrins, Carl John Gallagher and Sean Edward Gallagher
    Transactions
    • 28 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 19 nov. 1998
    Livré le 27 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RUSKIN CAMWAY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juin 2010Commencement of winding up
    29 sept. 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicola Jayne Fisher
    Satago Cottage 360a Brighton Road
    CR2 6AL Croydon
    practitioner
    Satago Cottage 360a Brighton Road
    CR2 6AL Croydon
    Christopher Herron
    Satago Cottage 360a Brighton Road
    CR2 6AL Croydon
    practitioner
    Satago Cottage 360a Brighton Road
    CR2 6AL Croydon

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0