CP 100 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCP 100 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03590026
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CP 100 LIMITED ?

    • (7222) /

    Où se situe CP 100 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CP 100 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COPPEREYE LIMITED09 janv. 200109 janv. 2001
    INDIGO ONE TECHNOLOGIES LIMITED 22 juin 199922 juin 1999
    INDIGO ONE TECHNOLOGY LIMITED18 mai 199918 mai 1999
    GODZILLA LIMITED30 juin 199830 juin 1998

    Quels sont les derniers comptes de CP 100 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour CP 100 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 mars 2012

    14 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 16 mars 2012

    14 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 sept. 2011

    12 pages2.24B

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator :- r h Pick replaces f c Satow
    6 pagesLIQ MISC OC

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    7 pages2.39B

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    23 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Suite 47, Aztec Centre Aztec West Almondsbury Bristol Bristol and Ne Somerset BS32 4TD le 14 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Carmen Carey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 oct. 2010

    État du capital au 22 oct. 2010

    • Capital: GBP 1,521,507.387
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carmen Carey le 30 juin 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Sian Castle en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ashley Cartman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Box House Box Corsham Wiltshire SN13 8AA le 29 juin 2010

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2009 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de CP 100 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASTLE, Sian
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Secrétaire
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    155108950001
    SNOW, Edward
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish120026800001
    SZPIRO, James Lucien Alexander
    Talbot Road
    W2 5JJ London
    51b
    Administrateur
    Talbot Road
    W2 5JJ London
    51b
    EnglandBritish136504450001
    CARTMAN, Ashley
    139 Brynland Avenue
    Bishopston
    BS7 9DZ Bristol
    Secrétaire
    139 Brynland Avenue
    Bishopston
    BS7 9DZ Bristol
    British119027760001
    PAULY, Duncan Gunther
    11 Downfield Close
    Alveston
    BS35 3NJ Bristol
    Secrétaire
    11 Downfield Close
    Alveston
    BS35 3NJ Bristol
    British31270490006
    BLACKFRIAR SECRETARIES LIMITED
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    Secrétaire désigné
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    900011530001
    ALI, Zahid
    9 Eaton Court
    48 Eaton Rise
    W5 2EU London
    Administrateur
    9 Eaton Court
    48 Eaton Rise
    W5 2EU London
    British69459930001
    CAREY, Carmen
    Linden Gardens
    W2 4HZ London
    Flat 6 61
    Administrateur
    Linden Gardens
    W2 4HZ London
    Flat 6 61
    United KingdomUnited States129984050001
    HABGOOD, Nicholas John
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish76793280001
    JOYCE, Richard William
    Swinley Court
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Swinley Court
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish74233810001
    KEMP, Nicholas
    The Old School
    Munslow
    SY7 9ET Craven Arms
    Shropshire
    Administrateur
    The Old School
    Munslow
    SY7 9ET Craven Arms
    Shropshire
    British77415980001
    MCCAFFERTY, Paul John
    Brockeridge Cottage
    4 Hillside Lane Frampton Cotterell
    BS36 2HZ Bristol
    Avon
    Administrateur
    Brockeridge Cottage
    4 Hillside Lane Frampton Cotterell
    BS36 2HZ Bristol
    Avon
    United KingdomBritish59596190002
    MITCHELL PALLANDRE, Kathleen
    80 Shorelands Drive
    Madison
    Ct 06443
    Usa
    Administrateur
    80 Shorelands Drive
    Madison
    Ct 06443
    Usa
    United StatesAmerican149414140001
    PAULY, Duncan Gunther
    23 Brunel Close
    Warmley
    BS30 5BB Bristol
    Administrateur
    23 Brunel Close
    Warmley
    BS30 5BB Bristol
    British31270490003
    ROGERSON, Philip Graham
    56 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    Administrateur
    56 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    British93942500001
    ROGERSON, Simon Andrew
    Pagoda Cottage
    Pagoda Gardens Blackheath
    SE3 0UZ London
    Administrateur
    Pagoda Cottage
    Pagoda Gardens Blackheath
    SE3 0UZ London
    British68877960002
    ROSE, Steven Christopher Enderwick
    Home Farm
    GU31 5BJ Rogate
    Hampshire
    Administrateur
    Home Farm
    GU31 5BJ Rogate
    Hampshire
    EnglandBritish190797440001
    RYAN, Peter
    Green Farm
    St Maughans
    NP25 5QG Monmouth
    Gwent
    Administrateur
    Green Farm
    St Maughans
    NP25 5QG Monmouth
    Gwent
    United KingdomBritish80305950004
    STEELE, Cameron
    575 Market Street, Suite 1975
    San Francisco
    California 94105
    Usa
    Administrateur
    575 Market Street, Suite 1975
    San Francisco
    California 94105
    Usa
    American113953550001
    SWANN, Allen Albert
    Ladyham
    Fulbrook
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Ladyham
    Fulbrook
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish234173890001
    TUCKER, John Anthony
    59 Warminster Road
    Bathampton
    BA2 6RX Bath
    Administrateur
    59 Warminster Road
    Bathampton
    BA2 6RX Bath
    British59596280001
    BLACKFRIAR DIRECTORS LIMITED
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    Administrateur désigné
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    900011520001

    CP 100 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2008
    Livré le 01 nov. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital 2008 L.P.
    Transactions
    • 01 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2007
    Livré le 03 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 03 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 22 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 22 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 13 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 13 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 déc. 2006
    Livré le 14 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 sept. 2006
    Livré le 28 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited (the Security Trustee)
    Transactions
    • 28 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 08 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee for itself and each of the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transactions
    • 08 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 12 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transactions
    • 12 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 06 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transactions
    • 06 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CP 100 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 avr. 2011Administration started
    16 mars 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Frederick Charles Satow
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0