TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03591323
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED03 juil. 199803 juil. 1998
    HURST NEWCO 2 LIMITED26 juin 199826 juin 1998

    Quels sont les derniers comptes de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 mars 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Satisfaction de la charge 035913230008 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 29 mars 2015

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Joanne Walker en tant que directeur le 22 juin 2015

    1 pagesTM01

    Statuts

    9 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2015

    État du capital au 28 mai 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 035913230008, créée le 15 avr. 2015

    31 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 035913230007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 035913230006 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Joanne Walker le 18 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Somerset le 17 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Sean Glithero le 17 mars 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Robert Glithero le 17 mars 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT à 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN le 23 déc. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 mars 2014

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tara Collet en tant que directeur le 03 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Ian Somerset en tant qu'administrateur le 25 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2014

    État du capital au 28 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Inscription de la charge 035913230007

    27 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GLITHERO, Sean
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Secrétaire
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    159905460001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Administrateur
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish129229070002
    SOMERSET, Ian
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Administrateur
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    British15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    United Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147214630001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    Administrateur
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish160951420001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Administrateur
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritish123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    British46555440002
    MCCALL, Carolyn Julia
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British39252480010
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Administrateur
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    WALKER, Joanne
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Administrateur
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish180119580001

    TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 avr. 2015
    Livré le 20 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited and Its Successors in Title and Permitted Transferees
    Transactions
    • 20 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2014
    Livré le 13 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 13 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2014
    Livré le 13 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 13 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Global accession deed
    Créé le 03 oct. 2003
    Livré le 10 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 10 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 19 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    Créé le 24 mai 2000
    Livré le 08 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 08 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Créé le 21 juil. 1998
    Livré le 07 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998
    Brèves mentions
    First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G.
    Transactions
    • 07 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 juil. 1998
    Livré le 07 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transactions
    • 07 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 mars 2016Commencement of winding up
    21 janv. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0