STUBAKER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTUBAKER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03606331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STUBAKER LIMITED ?

    • Coiffure et autres soins de beauté (96020) / Autres activités de services

    Où se situe STUBAKER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Aws Accountancy 3 Berrymoor Court
    Northumberland Business Park
    NE23 7RZ Cramlington
    Northumberland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STUBAKER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour STUBAKER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2015

    État du capital au 29 juil. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2014

    État du capital au 30 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    3 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 29 juil. 2013

    SH01

    Inscription de la charge 036063310005

    20 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Fiona Stuart en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    4 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de STUBAKER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STUART, Darren
    West Herrington
    DH4 4GD Houghton Le Spring
    The Stables
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    West Herrington
    DH4 4GD Houghton Le Spring
    The Stables
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    EnglandBritish140571390001
    STUART, Fiona
    West Herrington
    DH4 4GD Houghton Le Spring
    The Stables
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Secrétaire
    West Herrington
    DH4 4GD Houghton Le Spring
    The Stables
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    British140571360001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Secrétaire désigné
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    BAKER, Michael
    Parish View
    5 Pudding Chare
    NE1 1UE Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Parish View
    5 Pudding Chare
    NE1 1UE Newcastle Upon Tyne
    British59818520002
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Administrateur désigné
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STUBAKER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Darren Stuart
    3 Berrymoor Court
    Northumberland Business Park
    NE23 7RZ Cramlington
    Aws Accountancy
    Northumberland
    01 juil. 2016
    3 Berrymoor Court
    Northumberland Business Park
    NE23 7RZ Cramlington
    Aws Accountancy
    Northumberland
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    STUBAKER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2013
    Livré le 01 mai 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 2010
    Livré le 13 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 48 and 50 front street east boldon tyne and wear and l/h ground and basement floor at 40 west sunniside sunderland tyne and wear.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 01 mars 2006
    Livré le 07 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a 40 west sunniside sunderland. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 04 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    48/50 front street, east boldon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 2004
    Livré le 07 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0