BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03606581
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLINOVIA HOLDINGS LIMITED12 sept. 200312 sept. 2003
    LVL MEDICAL (UK) LTD11 oct. 200011 oct. 2000
    CLINOVIA HOLDINGS LIMITED30 juin 199930 juin 1999
    CAREMARK HOLDINGS LIMITED16 oct. 199816 oct. 1998
    OVAL (1346) LIMITED30 juil. 199830 juil. 1998

    Quels sont les derniers comptes de BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Cessation de la nomination de Nicholas Tetley Beazley en tant que directeur le 19 mai 2013

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA le 10 janv. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2012

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Mahboob Ali Merchant en tant que directeur le 10 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Robert Taylor en tant que directeur le 15 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Ellerby en tant que directeur le 01 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 août 2012

    État du capital au 02 août 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    legacy

    3 pagesSH20

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    État du capital au 09 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    37 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Stuart Sheehy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Robert Taylor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mark Ellerby en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Secrétaire
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    FLANAGAN, Stephen David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish117787010001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    BRASSINGTON, David John
    The Willows
    37 New Road
    AL6 0AQ Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Willows
    37 New Road
    AL6 0AQ Welwyn
    Hertfordshire
    British94323000001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    WADDELL, Ian Francis
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    British28497990001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ADLER, Daniel Andrew
    25 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LJ London
    Administrateur
    25 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LJ London
    United KingdomBritish153729250001
    AYLWIN, Andrew Richard
    138 Trevelyan Road
    Tooting
    SW17 9LW London
    Administrateur
    138 Trevelyan Road
    Tooting
    SW17 9LW London
    United KingdomBritish124750150001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    BRASSINGTON, David John
    The Willows
    37 New Road
    AL6 0AQ Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Willows
    37 New Road
    AL6 0AQ Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish94323000001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    BUSCOMBE, Philip John
    The Ferry House Ferry Lane
    Goring On Thames
    RG8 9DX Reading
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Ferry House Ferry Lane
    Goring On Thames
    RG8 9DX Reading
    Oxfordshire
    EnglandBritish47503900001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    ELLERBY, Mark
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish40582650004
    FLETCHER, David Robert Ross
    140 Station Road
    AL5 4RH Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    140 Station Road
    AL5 4RH Harpenden
    Hertfordshire
    British67346040001
    GREGORY, Fraser David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish107664270003
    KEE, Fergus Alexander
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    LAVOREL, Benjamin
    Chemin Du Bois
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    Administrateur
    Chemin Du Bois
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    French70949410001
    LAVOREL, Jean-Claude
    Chemin Du Bois
    Caluire Du Bois
    69300
    France
    Administrateur
    Chemin Du Bois
    Caluire Du Bois
    69300
    France
    French70900190001
    LAVOREL, Stanislas
    Chemin Du Bois
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    Administrateur
    Chemin Du Bois
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    French70900270001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish56732410001
    METZELER, Severine
    41 Rue Nuzilly
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    Administrateur
    41 Rue Nuzilly
    Caluire Et Cuire
    69300
    France
    French70900340001
    SCOREY, Michael George
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    Administrateur
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    United KingdomBritish1749220001
    SHAW, Joanna Mary
    8 Cowbridge
    SG14 1PQ Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Cowbridge
    SG14 1PQ Hertford
    Hertfordshire
    British92201390001
    SHEEHY, Stuart David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish123217250001
    SPOORS, Mark
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    British72289290002
    TAYLOR, Neil Robert
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish62846800003
    WADDELL, Ian Francis
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish28497990001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 août 2003
    Livré le 29 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 29 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 sept. 2002
    Livré le 17 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 23 sept. 1998
    Livré le 02 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 janv. 2014Dissolved on
    21 déc. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0