LEGION FM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEGION FM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03611290
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEGION FM LIMITED ?

    • (7524) /

    Où se situe LEGION FM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 14 The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEGION FM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEGION FM PLC01 juil. 200901 juil. 2009
    LEGION GROUP PLC06 oct. 200506 oct. 2005
    LEGION SECURITY PLC03 août 199803 août 1998

    Quels sont les derniers comptes de LEGION FM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LEGION FM LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LEGION FM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pages4.72

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 déc. 2014

    14 pages4.68

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2014

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2013

    16 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * 43-45 Portman Square London W1H 6LY* le 22 juil. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2012

    15 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 juil. 2011

    24 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    20 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 05 févr. 2011

    17 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    45 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * Hanover House Queensgate Britannia Road Waltham Cross Hertfordshire EN8 7TF* le 25 août 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    11 pagesMG01

    Nomination de Mr Stephen Charles Thomas en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Charles Cleverly en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    7 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de LEGION FM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HIGGINS, Mark Anthony
    Vicarage Hill
    B94 5EA Tanworth In Arden
    Ashwood
    West Midlands
    Administrateur
    Vicarage Hill
    B94 5EA Tanworth In Arden
    Ashwood
    West Midlands
    EnglandBritish137468740001
    THOMAS, Stephen Charles
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 14 The Shard
    Administrateur
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 14 The Shard
    United KingdomBritish66198390011
    THOMAS, Stephen Charles
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    Administrateur
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    United KingdomBritish66198390006
    CAMPBELL-SMITH, Ronald Harry
    13 Beech Road
    Beetley
    NR20 4EZ Dereham
    Norfolk
    Secrétaire
    13 Beech Road
    Beetley
    NR20 4EZ Dereham
    Norfolk
    British40563810001
    KELLY, Gerard Francis Matthew
    57 Newlands Avenue
    WD7 8EJ Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    57 Newlands Avenue
    WD7 8EJ Radlett
    Hertfordshire
    British38588150001
    LAWRENCE, Adrian
    9 Stoneleigh Grove
    TF2 8SU Telford
    Shropshire
    Secrétaire
    9 Stoneleigh Grove
    TF2 8SU Telford
    Shropshire
    British112935750001
    LEE, Sandra Dawn
    Victoria Park Avenue
    PR25 1UG Leyland
    64
    Lancashire
    Secrétaire
    Victoria Park Avenue
    PR25 1UG Leyland
    64
    Lancashire
    British128499960001
    ATKINSON, Daniel Edward
    4 The Coppice
    Rothwell Road
    HX1 2HF Halifax
    Administrateur
    4 The Coppice
    Rothwell Road
    HX1 2HF Halifax
    United KingdomBritish56345130002
    CALDER, Robin
    The Old Post Office
    46 Mill Road
    TF9 3NB Wollerton
    Shropshire
    Administrateur
    The Old Post Office
    46 Mill Road
    TF9 3NB Wollerton
    Shropshire
    United KingdomBritish78203660001
    CAMPBELL-SMITH, Ronald Harry
    13 Beech Road
    Beetley
    NR20 4EZ Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    13 Beech Road
    Beetley
    NR20 4EZ Dereham
    Norfolk
    EnglandBritish40563810001
    CLEVERLY, Charles John
    Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    19
    West Midlands
    Administrateur
    Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    19
    West Midlands
    United KingdomBritish134606530001
    ELLIOTT, John Russell
    Arden House 20 Saint Thomas Hill
    CT2 8EH Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Arden House 20 Saint Thomas Hill
    CT2 8EH Canterbury
    Kent
    British84668750001
    EVANS, David Russell
    Bullen Cottage
    Addlestead Road East Peckham
    TN12 5NN Tonbridge
    Administrateur
    Bullen Cottage
    Addlestead Road East Peckham
    TN12 5NN Tonbridge
    EnglandBritish51435150001
    GOODLIFE, Peter
    21 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    21 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    British84668880001
    GREENAWAY, Stephen John
    Chorley Road
    West Wycombe
    HP14 3AR High Wycombe
    30
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Chorley Road
    West Wycombe
    HP14 3AR High Wycombe
    30
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish129235200001
    KELLY, Gerard Francis Matthew
    57 Newlands Avenue
    WD7 8EJ Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    57 Newlands Avenue
    WD7 8EJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish38588150001
    KOLBE, Brian Malcolm
    Glenesk The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    Administrateur
    Glenesk The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish48582900001
    LAWRENCE, Adrian
    9 Stoneleigh Grove
    TF2 8SU Telford
    Shropshire
    Administrateur
    9 Stoneleigh Grove
    TF2 8SU Telford
    Shropshire
    EnglandBritish112935750001
    MACKINLAY, Hamish Grant
    The Horse Shoes
    The Green, Gressenhall
    NR20 4DT Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    The Horse Shoes
    The Green, Gressenhall
    NR20 4DT Dereham
    Norfolk
    EnglandBritish45597880002
    MANSFORD, John
    26 Belton Hill
    Fulwood
    PR2 3SU Preston
    Lancashire
    Administrateur
    26 Belton Hill
    Fulwood
    PR2 3SU Preston
    Lancashire
    British111206630001
    SINCLAIR, Hunter
    The White House 31 St Peters Park Road
    CT10 2BG Broadstairs
    Kent
    Administrateur
    The White House 31 St Peters Park Road
    CT10 2BG Broadstairs
    Kent
    British61719150001
    SMITH, Derek
    Wits End
    Rudyard
    ST13 8RU Leek
    Staffordshire
    Administrateur
    Wits End
    Rudyard
    ST13 8RU Leek
    Staffordshire
    United KingdomBritish83362540002
    SWITZER, David
    173 Baldock Road
    SG6 2EJ Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    173 Baldock Road
    SG6 2EJ Letchworth
    Hertfordshire
    British26409760001
    WALKER, John Binnie
    Laikin View
    Pennine Way
    CA11 9QW Calthwaite
    15
    Cumbria
    Administrateur
    Laikin View
    Pennine Way
    CA11 9QW Calthwaite
    15
    Cumbria
    British133990490001
    WHEELDON, John Michael
    6 Larks Gate
    Fornham All Saints
    IP28 6HY Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    6 Larks Gate
    Fornham All Saints
    IP28 6HY Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British5007050003
    WILKINSON, Gerald Charles
    28 Acacia Avenue
    UB3 2ND Hayes
    Middlesex
    Administrateur
    28 Acacia Avenue
    UB3 2ND Hayes
    Middlesex
    British57772520001
    WOOD, Francis David Andrew
    Orchard House 136 Rochdale Road
    Greetland
    HX4 8JE Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Orchard House 136 Rochdale Road
    Greetland
    HX4 8JE Halifax
    West Yorkshire
    British38777560001

    LEGION FM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 juil. 2010
    Livré le 17 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or ot become due from legion group PLC to the chargee and/or the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mark Higgins (As Security Agent and Trustee for All the "Noteholders")
    Transactions
    • 17 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 20 janv. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in gbp designated ltsb rg legion group PLC and numbered 03328018 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 19 mars 2009
    Livré le 28 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 28 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Lease
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £4,214 to be held in an interest earning account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cambridge Research Park Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 10 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Markham house 33-39 garstang road preston lancashire t/n LA119253, LA340645, LA499805 and LA515819. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 08 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 08 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 10 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 rathmore road charlton london SE7 t/no: SGL477839. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 juin 1999
    Livré le 10 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 27 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in accordance with the provisions of a loan stock instrument of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal British Legion Attendants Company Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LEGION FM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 août 2010Administration started
    29 juil. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Neville Whitfield
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul John Clark
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DateType
    29 juil. 2011Commencement of winding up
    18 déc. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul John Clark
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    John Neville Whitfield
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0