THE M W GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE M W GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03622514
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE M W GROUP LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe THE M W GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Aurum House 2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE M W GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DMWSL 241 LIMITED26 août 199826 août 1998

    Quels sont les derniers comptes de THE M W GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour THE M W GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juil. 2010

    État du capital au 13 juil. 2010

    • Capital: GBP 11,657,181.35
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2010

    4 pagesAA

    Comptes annuels établis au 01 févr. 2009

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Edwin Gerrard le 05 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Gillian Oliff le 05 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Clive Sargent le 05 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Paul David Stead le 05 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Broderick le 05 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 03 févr. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 27 janv. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de THE M W GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OLIFF, Gillian
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Secrétaire
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    British128108960001
    BRODERICK, Anthony John
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Administrateur
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishSales Director98431500001
    GERRARD, Richard Edwin
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Administrateur
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishDirector124068680001
    SARGENT, Stephen Clive
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Administrateur
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishCompany Director16905350005
    STEAD, Justin Paul David
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Administrateur
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandAustralianChief Executive116638810003
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishGroup Retatil Operation Dir61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    LOBB, Andrew Mark
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    Secrétaire
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    British74760630002
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    BritishFinance Director62321110002
    STOCKTON, Neil David
    22 Dedmere Road
    SL7 1PG Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    22 Dedmere Road
    SL7 1PG Marlow
    Buckinghamshire
    British66840360001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Administrateur
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritishDirector92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritishDirector69874610002
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Administrateur
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    BritishDirector92733900001
    DOWNES, Paul William Edwin
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    Administrateur
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Banker18135910002
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Administrateur
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritishDirector57490310002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishGroup Retail Operations Dir61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector64357220001
    MASON, Robert Sturdee
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    Administrateur
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    EnglandBritishBanker149738610001
    MCCLOSKEY, Ciaran
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    Administrateur
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    BritishDirector88312080001
    PIASECKI, Jerzy Stanislaw
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    Administrateur
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    EnglandBritishDirector129561330001
    PILKINGTON, Judith Mary
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    Administrateur
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    United KingdomBritishCeo106791670001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director62321110002
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Administrateur
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandicDirector114179720001
    SUMMERS, Jeffrey
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    BritishMerchandise Director127606650001
    WEST, James Edward
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director14107350002
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Administrateur
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    THE M W GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of debenture
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 02 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H basement ground first and second floors 1 commercial street leeds t/no WYK477698 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Islands Hf
    Transactions
    • 02 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Créé le 05 juin 2001
    Livré le 13 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 13 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman insurance assignment under tranche a loan agreement
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 23 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in connection with the loan agreement (as defined) and loan documents
    Brèves mentions
    (I) scottish provident life assurance policy (policy no:3739313H) dated 25/2/99 in favour of judith pilkington for £1,000,000 for 5 years and (ii) guardian assurance PLC life assurance policy (policy no:L0193248411) dated 25/2/99 in favour of mark fisher for £500,000 for 5 years; all benefits and proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.,as Agent and Trustee for Each of the Lenders (As Defined)
    Transactions
    • 23 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement of even date and the loan documents (as defined)
    Brèves mentions
    All the company's interest and benefit in and to the policies and all proceeds and related rights thereto and thereof with life policies being 1), policy number 32188/077/crd with alder life dated 18.12.98 for the term of 2 months on the life of judith pilkington for the sum of £1,000,000 and 2). policy no. 32188/078/Crd with alder life dated 18.12.98 for the terms of 2 months on the life of mark fisher for the sum of £500,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0