DUBSAT LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUBSAT LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03623728
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUBSAT LTD ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DUBSAT LTD ?

    Adresse du siège social
    Berkshire House 7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUBSAT LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VIO WORLDWIDE LIMITED25 août 199825 août 1998

    Quels sont les derniers comptes de DUBSAT LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour DUBSAT LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Dubsat Pty Ltd Omnilab Building Level 1 4-16 Yurong Street East Sydney Nsw 2010 Australia à 7th Floor Berkshire House 168 - 173 High Holborn London WC1V 7AA

    1 pagesAD02

    Cessation de Christopher Mapp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2016

    1 pagesPSC07

    Notification de Citizen Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2016

    17 pagesAA

    État du capital au 30 janv. 2017

    • Capital: GBP 100.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of the share premium account 30/01/2017
    RES13

    Nomination de Mr Gerald Sutton en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Warwick Syphers en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Grahame Edgar Mapp en tant que directeur le 01 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher James Mapp en tant que directeur le 01 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 1 Primrose Street London EC2A 2EX England à Berkshire House 7th Floor 168 - 173 High Holborn London WC1V 7AA le 04 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Daniel Charles Mark en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Edgar Mapp le 24 févr. 2016

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR à 1 Primrose Street London EC2A 2EX le 01 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2015

    État du capital au 22 sept. 2015

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2014

    État du capital au 14 oct. 2014

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de DUBSAT LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARK, Daniel Charles
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    Administrateur
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer152118240001
    SUTTON, Gerald
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    Administrateur
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    United StatesAustralianChief Executive220024720001
    SYPHERS, Warwick
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    Administrateur
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    United StatesAustralianCommercial Director218183690001
    BRITTON, Roderick
    Admiralty Way
    TW11 0NL Teddington
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Admiralty Way
    TW11 0NL Teddington
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    British153708210001
    ERRINGTON, Mark Richard
    17 Chantry Road
    KT16 8NH Chertsey
    Surrey
    Secrétaire
    17 Chantry Road
    KT16 8NH Chertsey
    Surrey
    British101499420001
    FLETCHER, Mark Peter
    63 Shaftesbury Crescent
    Laleham
    TW18 1QL Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    63 Shaftesbury Crescent
    Laleham
    TW18 1QL Staines
    Middlesex
    BritishChief Finance Officer87200460001
    HILTON, Timothy James
    Embley Park
    SO51 6DL Romsey
    Embley Thorpe
    Hampshire
    Secrétaire
    Embley Park
    SO51 6DL Romsey
    Embley Thorpe
    Hampshire
    British135620960001
    HORWOOD, Richard Jonathan
    3 The Mount
    Hampstead
    NW3 6SZ London
    Secrétaire
    3 The Mount
    Hampstead
    NW3 6SZ London
    BritishCompany Director19032710001
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British76739920001
    SPIERS, Stuart Alexander
    Briarpatch
    Hogspudding Lane Newdigate
    RH5 5DU Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Briarpatch
    Hogspudding Lane Newdigate
    RH5 5DU Dorking
    Surrey
    BritishManaging Director Europe108644400001
    NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Secrétaire
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    45816950001
    BARNSLEY, John Corbitt
    8 Montpelier Terrace
    Knightsbridge
    SW7 1JP London
    Administrateur
    8 Montpelier Terrace
    Knightsbridge
    SW7 1JP London
    Great BritainBritishCompany Director45082740001
    CAPE, Jonathan Richard
    138 Victoria Rise
    SW4 0NW London
    Administrateur
    138 Victoria Rise
    SW4 0NW London
    BritishCompany Director58185080001
    CHELOUCHE, Yoav Zadock
    53 Lamerchav Street
    47226 Ramat Hasharon
    Israel
    Administrateur
    53 Lamerchav Street
    47226 Ramat Hasharon
    Israel
    IsraeliCompany Executive45895090001
    CLUTTON, Steven
    35 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Administrateur
    35 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    BritishFinancial Director70514030001
    DESHEH, Eyal
    49 Zamir Street
    Mavaseret Zion 90805
    Israel
    Administrateur
    49 Zamir Street
    Mavaseret Zion 90805
    Israel
    IsraeliCompany Executive58379600001
    DOOL, Richard
    2 Meadowlark Court
    FOREIGN Flemington
    New Jersey 08822
    U S A
    Administrateur
    2 Meadowlark Court
    FOREIGN Flemington
    New Jersey 08822
    U S A
    AmericanDirector98700230001
    FRIEND, Christopher John
    1 The Old House
    Ickwell Green
    SG18 933 Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    1 The Old House
    Ickwell Green
    SG18 933 Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director15164890002
    GREEN, Colin Raymond
    131 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    Administrateur
    131 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    BritishSolicitor40013590002
    HABGOOD, Nicholas John
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishVenture Capitalist76793280001
    HALEVY, Itai Ben Zion
    78 Gilad Street
    Kochav Yair 44864
    Israel
    Administrateur
    78 Gilad Street
    Kochav Yair 44864
    Israel
    IsraeliCompany Executive69951370001
    HARWOOD, Robert John
    19 Nairn Court
    Trinity Road Wimbledon
    SW19 8QT London
    Administrateur
    19 Nairn Court
    Trinity Road Wimbledon
    SW19 8QT London
    BritishChartered Secretary56471970002
    HORWOOD, Richard Jonathan
    3 The Mount
    Hampstead
    NW3 6SZ London
    Administrateur
    3 The Mount
    Hampstead
    NW3 6SZ London
    United KingdomBritishCompany Director19032710001
    MAPP, Christopher James
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    Administrateur
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    AustraliaAustralianNone155490830001
    MAPP, Grahame Edgar
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    Administrateur
    7th Floor
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    England
    AustraliaAustralianNone155182050002
    MELTZER, Erez
    55 Hama'Ayan Street
    43569 Ra'Anana
    Israel
    Administrateur
    55 Hama'Ayan Street
    43569 Ra'Anana
    Israel
    Israeli & U.S.Company Executive60568820001
    MILLS, Graham Steven
    1 Brookfields
    Pavenham
    MK43 7QA Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    1 Brookfields
    Pavenham
    MK43 7QA Bedford
    Bedfordshire
    BritishBt Senior Manager66552820001
    PEXTON, Martin Andrew
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    EnglandBritishCo Director87643530001
    SCHRAER, Michael Alexander
    33 Newcombe Park
    Mill Hill
    NW7 3QN London
    Administrateur
    33 Newcombe Park
    Mill Hill
    NW7 3QN London
    EnglandBritishFinance Director Internet And61950690003
    SNOW, Edward
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInvestment Manager120026800001
    SWINGEWOOD, John Paul
    Rogers Farm
    Lunces Common
    RH16 4QU Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Rogers Farm
    Lunces Common
    RH16 4QU Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director141447260001
    THOMAS, Graham Neil
    10 The Drive
    Fetcham
    KT22 9EN Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    10 The Drive
    Fetcham
    KT22 9EN Leatherhead
    Surrey
    BritishAccountant104110660001
    WALKER, Katherine Ann
    1 Cypress Grove
    TN2 5JR Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    1 Cypress Grove
    TN2 5JR Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Secretary56816310001
    WALSH, Paula Annette
    10 Silverfield
    EN10 6PD Broxbourne
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Silverfield
    EN10 6PD Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary2915090012
    WILSON, David Andrew
    April Wood St Marys Road
    SL5 9AY Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    April Wood St Marys Road
    SL5 9AY Ascot
    Berkshire
    EnglandUnited KingdomExecutive38114230001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUBSAT LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Christopher Mapp
    Level 1, 4-16 Yurong St
    East Sydney
    Omnilab
    Nsw 2010
    Australia
    06 avr. 2016
    Level 1, 4-16 Yurong St
    East Sydney
    Omnilab
    Nsw 2010
    Australia
    Oui
    Nationalité: Australian
    Pays de résidence: Australia
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Citizen Limited
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    7th Floor Berkshire House
    England
    06 avr. 2016
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    7th Floor Berkshire House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    DUBSAT LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 mai 2009
    Livré le 02 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital 2009 L.P.
    Transactions
    • 02 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 oct. 2008
    Livré le 23 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital 2008 L.P.
    Transactions
    • 23 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westpool Investment Trust PLC
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2007
    Livré le 03 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 03 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 déc. 2006
    Livré le 19 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westpool Investment Trust Public Limited Company
    Transactions
    • 19 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 2006
    Livré le 20 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 20 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 juin 2006
    Livré le 07 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 févr. 2006
    Livré le 06 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 06 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 juin 2005
    Livré le 30 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 30 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 oct. 2003
    Livré le 05 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westpool Investment Trust PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 09 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 09 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2002
    Livré le 05 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 05 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 10 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Details of charged account: barclays bank PLC re vio worldwide limited business premium account number 70931500. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 avr. 2002
    Livré le 26 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 26 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2002
    Livré le 05 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transactions
    • 05 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of deposit
    Créé le 03 nov. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The deposit balance standing to the credit of an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0