OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03624817 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?
Adresse du siège social | Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull West Midlands |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Oxford Business Park (South) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Martin Cornell le 01 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 01 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ancosec Limited le 01 sept. 2013 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Arlington House Arlington Business Park Theale, Reading Berkshire RG7 4SA* le 02 sept. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 17 déc. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 18 déc. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCOSEC LIMITED | Secrétaire | Central Boulevard Shirley B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | 111724450001 | |||||||
CORNELL, James Martin | Administrateur | Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | England | British | Treasurer | 148803950001 | ||||
REED, Robert Paul | Administrateur | Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | England | British | Director Of Finance And Reporting | 148032280006 | ||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Secrétaire | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||
LYNE, Sarah Jane | Secrétaire | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||
READ, Jonathan David | Secrétaire | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
AUSTEN, Jonathan Martin | Administrateur | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | Director | 51921200001 | ||||
BRAND, Duncan Valentine | Administrateur | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 16800690001 | ||||
CHATER, Beth Salena | Administrateur | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 60464290003 | ||||
DEIGMAN, Patrick | Administrateur | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Building Surveyor | 37099910001 | ||||
DOLLINGER, Susan Betty | Administrateur | 285 Smith Ridge Road South Salem NY10590 New York United States | American | Banker | 67797660001 | |||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Administrateur | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 49654480002 | ||||
MOHANLAL, Satish | Administrateur | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | Finance Director | 51579180001 | |||||
MURRAY, Nicholas Stuart Granville | Administrateur | Oak House 51 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | Development Surveyor | 29664370001 | ||||
PEDLOW, Joseph Martin | Administrateur | 24 Eton Avenue NW3 3HL London | American | Banker | 55169650001 | |||||
POPE, Nigel Howard | Administrateur | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | Chartered Accountant | 29583660002 | ||||
PULSFORD, Jeffrey Mark | Administrateur | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 49776690004 | ||||
SIMKIN, Richard William | Administrateur | 14 Little Plucketts Way IG9 5QU Buckhurst Hill Essex | England | British | Director | 13432460001 | ||||
THOMSON, Amanda Jane | Administrateur | Flat 2 43 Eton Avenue Belsize Park NW3 3EP London | United Kingdom | British | Banker | 47240760001 | ||||
YOUNG, William John | Administrateur | Whiteladyes Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | American | Banker | 61300850001 | |||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford Business Park (South) Limited | 06 avr. 2016 | Central Boulevard Blythe Valley Park, Shirley B90 8BG Solihull Nelson House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 13 nov. 1998 Livré le 01 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents together with all expenses | |
Brèves mentions F/H land being plot 4000 oxford business park oxfordshire t/no.ON156345 and all buildings and other structures fixtures fixed plant machinery & equipment. Assigns all rental and other income. Charges all deeds or documents relating to the property. By way of floating charge the undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Account charge | Créé le 13 nov. 1998 Livré le 26 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement of even date and on any account whatsoever | |
Brèves mentions All its right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0