OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED

OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03624817
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Nelson House
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Oxford Business Park (South) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2016

    État du capital au 21 juin 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 sept. 2015

    État du capital au 07 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2014

    État du capital au 08 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Martin Cornell le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2013

    État du capital au 09 sept. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ancosec Limited le 01 sept. 2013

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Arlington House Arlington Business Park Theale, Reading Berkshire RG7 4SA* le 02 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 17 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 18 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANCOSEC LIMITED
    Central Boulevard Shirley
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Secrétaire
    Central Boulevard Shirley
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    EnglandBritishTreasurer148803950001
    REED, Robert Paul
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector Of Finance And Reporting148032280006
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Secrétaire
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51921200001
    BRAND, Duncan Valentine
    Westmill House
    SG12 0ET Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westmill House
    SG12 0ET Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant16800690001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant60464290003
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishBuilding Surveyor37099910001
    DOLLINGER, Susan Betty
    285 Smith Ridge Road
    South Salem
    NY10590 New York
    United States
    Administrateur
    285 Smith Ridge Road
    South Salem
    NY10590 New York
    United States
    AmericanBanker67797660001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor49654480002
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Administrateur
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    BritishFinance Director51579180001
    MURRAY, Nicholas Stuart Granville
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDevelopment Surveyor29664370001
    PEDLOW, Joseph Martin
    24 Eton Avenue
    NW3 3HL London
    Administrateur
    24 Eton Avenue
    NW3 3HL London
    AmericanBanker55169650001
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Administrateur
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant29583660002
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant49776690004
    SIMKIN, Richard William
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    Administrateur
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritishDirector13432460001
    THOMSON, Amanda Jane
    Flat 2 43 Eton Avenue
    Belsize Park
    NW3 3EP London
    Administrateur
    Flat 2 43 Eton Avenue
    Belsize Park
    NW3 3EP London
    United KingdomBritishBanker47240760001
    YOUNG, William John
    Whiteladyes Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Whiteladyes Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    AmericanBanker61300850001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Oxford Business Park (South) Limited
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park, Shirley
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    England
    06 avr. 2016
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park, Shirley
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement2979018
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    OXFORD BUSINESS PARK (PLOT 4000) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 13 nov. 1998
    Livré le 01 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents together with all expenses
    Brèves mentions
    F/H land being plot 4000 oxford business park oxfordshire t/no.ON156345 and all buildings and other structures fixtures fixed plant machinery & equipment. Assigns all rental and other income. Charges all deeds or documents relating to the property. By way of floating charge the undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V.
    Transactions
    • 01 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Account charge
    Créé le 13 nov. 1998
    Livré le 26 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement of even date and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 26 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0