HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC

HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03627383
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    Tong Hall
    Tong Lane
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERACTIVITY GROUP PLC14 mai 200114 mai 2001
    MYVAL.COM PLC05 nov. 199805 nov. 1998
    OMEGA INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED07 sept. 199807 sept. 1998

    Quels sont les derniers comptes de HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    21 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    19 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    18 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    18 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    18 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    18 pagesWU07

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Progress report ends 14/08/2016
    14 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 14/08/2015
    8 pagesLIQ MISC

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    pagesCOCOMP

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Liquidator's Progress Report :- 15/08/2013 - 14/08/2014
    9 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's progress report :- 15/08/2012-14/08/2013
    9 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:annual report 15/08/11 to 14/08/12
    8 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:annual progress report - brought down date 14TH august 2012
    8 pagesLIQ MISC

    Changement d'adresse du siège social de , Finn Associates, Tong Hall Tong Lane, Bradford, West Yorkshire, BD4 0RR le 09 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Changement d'adresse du siège social de , 822 Fountain Court, Birchwood Boulevard Birchwood, Warrington, WA3 7QZ, England le 24 août 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de John Honey en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Goronwy Ffoulkes Davies en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Goronwy Ffoulkes Davies en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    État du capital après une attribution d'actions au 11 déc. 2009

    • Capital: GBP 9,964,192.192
    6 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 30 avr. 2010

    • Capital: GBP 9,964,192.192
    6 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    Administrateur
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United KingdomAustralianFinance Director133660360001
    GUNN, John Humphrey
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Administrateur
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    EnglandBritishDirector705110002
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director54189670005
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Secrétaire
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianFinance Director65921870004
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Secrétaire
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianFinance Director65921870004
    HYAMS, Anthony Harry
    102 Wolmer Gardens
    HA8 8QE Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    102 Wolmer Gardens
    HA8 8QE Edgware
    Middlesex
    British44815230001
    MACKAY, Thomas Alexander
    Lorton
    Toys Hill
    TN16 1QG Westerham
    Kent
    Secrétaire
    Lorton
    Toys Hill
    TN16 1QG Westerham
    Kent
    British44658840001
    SARGENT, Rodger David
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    Secrétaire
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    BritishDirector56891450002
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Secrétaire désigné
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    AKERS, Chris
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    Administrateur
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    BritishCompany Director77057180001
    BECKETT, Phillip
    6 Springfields
    HP6 5JU Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 Springfields
    HP6 5JU Amersham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director70362260001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishFinance Director54189670005
    BRIGGS, Michael
    Unit 1 1/2 Bramham Gardens
    South Kensington
    SW5 0JQ London
    Administrateur
    Unit 1 1/2 Bramham Gardens
    South Kensington
    SW5 0JQ London
    AustralianCompany Director38666330001
    BRIGSTOCKE, Nicholas Owen
    St Anns
    Sheep Lane
    GU29 9NT Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    St Anns
    Sheep Lane
    GU29 9NT Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritishNon Executive Director98249500004
    BRUCK, Stuart
    416 31st Street
    Manhattan Beach
    FOREIGN Los Angeles
    California 90266
    United States
    Administrateur
    416 31st Street
    Manhattan Beach
    FOREIGN Los Angeles
    California 90266
    United States
    AmericanExecutive Chairman88492530001
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    Administrateur
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    AmericanAttorney93963450001
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant79348050002
    HONEY, John Charles
    Greenways
    Lambourn
    RG17 7LH Hungerford
    Meridan House Std
    Berkshire
    Administrateur
    Greenways
    Lambourn
    RG17 7LH Hungerford
    Meridan House Std
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director129122500001
    HUNTER, David James
    43a Church Lane
    Hornsey
    N8 7BT London
    Administrateur
    43a Church Lane
    Hornsey
    N8 7BT London
    IrishCompany Director42626990001
    JONES, John Charles
    Villa Esterel 8 Avenue Victoria
    Le Cannet Alpes Maritimes
    FOREIGN France 06110
    Administrateur
    Villa Esterel 8 Avenue Victoria
    Le Cannet Alpes Maritimes
    FOREIGN France 06110
    BritishEngineer60913620001
    KLEIN, Robin Matthew
    5 Upper Terrace
    Hampstead
    NW3 6RH London
    Administrateur
    5 Upper Terrace
    Hampstead
    NW3 6RH London
    EnglandBritishCompany Director56477530001
    LAMEY, Richard
    11 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Administrateur
    11 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    BritishExecutive69447160001
    LOW, Michael Kingman
    6733 Abbottswood Drive
    Rancho Palos Verdes
    California 90275
    Usa
    Administrateur
    6733 Abbottswood Drive
    Rancho Palos Verdes
    California 90275
    Usa
    UsaChief Operating Officer88429400001
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director211557370001
    MCNAIR, Stewart Andrew
    5 The Links
    Burleigh Road
    SL5 7TN Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    5 The Links
    Burleigh Road
    SL5 7TN Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director42069020001
    MOORE, Anthony Roger
    7023 Pelican Island Drive
    FOREIGN Tampa
    Fl 33634
    Usa
    Administrateur
    7023 Pelican Island Drive
    FOREIGN Tampa
    Fl 33634
    Usa
    British UsNon Executive Director88429330001
    PERSKE, Graham Anderson
    Flat 2-3
    23 Upperphillimore Gardens Kensingto
    W8 7HF London
    Administrateur
    Flat 2-3
    23 Upperphillimore Gardens Kensingto
    W8 7HF London
    United KingdomAustralianCompany Director17802460001
    SARGENT, Rodger David
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    Administrateur
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    BritishDirector56891450002
    SHEARER, Anthony Presley
    63a Holland Park
    W11 3SJ London
    Administrateur
    63a Holland Park
    W11 3SJ London
    United KingdomBritishCompany Director115276930001
    STIMSON, Geoffrey George
    38 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    Administrateur
    38 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director2201630001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Administrateur
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritishNon Executive Director109723760001
    WARNER, Rufus Andrew Douglas
    Cotchet Farm House
    Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Cotchet Farm House
    Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director57560750002
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    Administrateur
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    BritishDirector136141810001
    WRAY, Nigel William
    The Priory
    54 Totteridge Village
    N20 8PS London
    Administrateur
    The Priory
    54 Totteridge Village
    N20 8PS London
    United KingdomBritishCompany Director45400750007

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 26 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over its undertaking all present and future assets together with all associated rights of any kind.
    Personnes ayant droit
    • John Humphrey Gunn (The Security Trustee)
    Transactions
    • 26 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 juil. 2006
    Livré le 07 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Créé le 27 juil. 2006
    Livré le 07 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1 ordinary share of £1 fully paid in the capital of safa - ips healthcare limited company number 5173653. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Créé le 04 janv. 2005
    Livré le 05 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank specified in the schedule to the memorandum. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Own account assignment of life policies
    Créé le 27 avr. 2004
    Livré le 28 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The polices and all amounts taht are to be paid under it and any amount to be paid on cancellation of the policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 22 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    £27,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit of £27,500.00 made by the company with lloyds tsb bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Moonstone Properties Limited
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over cash deposit
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By clause 4 of the charge, the company charges to the bank the charged property, by clause 5, the company undertakes that it shall not create or allow to subsist any security interest over the charged property except for any permitted security interest;.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By clause 2 of the memorandum, the company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank; clause 4, if at any time any further or other securities shall be deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By clause 2 of the memorandum, the company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank; clause 4, if at any time any further or other securities shall be deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over credit balances
    Créé le 12 juin 2003
    Livré le 18 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge over fluctuating deposits by the company, limited to £125,000.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 18 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Hunter
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mars 2022Conclusion of winding up
    08 juin 2011Petition date
    20 juil. 2011Commencement of winding up
    06 juil. 2022Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    The Official Receiver Or Chester
    The Official Receiver
    Suite5, 3rd Floor
    CH1 1DF Windsor House
    Pepper Street Chester
    practitioner
    The Official Receiver
    Suite5, 3rd Floor
    CH1 1DF Windsor House
    Pepper Street Chester
    Michael Field
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    practitioner
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    Paul Howard Finn
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    practitioner
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    James David Robinson
    Finn Associates Tong Hall
    Tong
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire
    practitioner
    Finn Associates Tong Hall
    Tong
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0