QUILLER ELECTRONICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUILLER ELECTRONICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03632967
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PENNYCOURT LIMITED17 sept. 199817 sept. 1998

    Quels sont les derniers comptes de QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Abacus House Bone Lane Newbury Berks RG14 5SF le 15 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2010

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Patrick Zammit en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Bielefeld en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 sept. 2010

    État du capital au 27 sept. 2010

    • Capital: GBP 125,002
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de QUILLER ELECTRONICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAN DER ZWALMEN, Anne
    Grimbergen
    Helman De Grimberghelaan 28
    1850
    Belgium
    Secrétaire
    Grimbergen
    Helman De Grimberghelaan 28
    1850
    Belgium
    BelgianBusiness Executive138188190001
    BIRK, David Ralph, Mr.
    East Corrine Drive
    Scottsdale
    Arizona
    12983
    Az 85259
    United States
    Administrateur
    East Corrine Drive
    Scottsdale
    Arizona
    12983
    Az 85259
    United States
    UsaAmericanBusiness Executive136282980001
    SADOWSKI, Raymond John
    13120 East Appaloosa Place
    Scottsdale
    Arizona 85259 Az
    Usa
    Administrateur
    13120 East Appaloosa Place
    Scottsdale
    Arizona 85259 Az
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive143504560001
    BATEMAN, Andrew
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    British24432680002
    HEFFERNAN, Liam Anthony
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    Secrétaire
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    British100478700001
    O'NEILL, Derek Patrick
    Oakley House, Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    Secrétaire
    Oakley House, Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    BritishDirector87909140001
    VAN DER PANT, Gavin Lawrence
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director72310190001
    ASHLEY SECRETARIES LIMITED
    Ashley House
    5 Grosvenor Square
    SO15 2BE Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Ashley House
    5 Grosvenor Square
    SO15 2BE Southampton
    Hampshire
    34342460005
    COURT SECRETARIES LTD
    209 Luckwell Road
    BS3 3HD Bristol
    Secrétaire désigné
    209 Luckwell Road
    BS3 3HD Bristol
    900001660001
    ALLEN, Peter Vance
    Buckholm Mill
    TD1 2HB Galashields
    Selkirkshire
    Administrateur
    Buckholm Mill
    TD1 2HB Galashields
    Selkirkshire
    Great BritainBritishDirector3711280004
    BARKER, Trevor John
    10 Solent Road
    BH6 4BP Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    10 Solent Road
    BH6 4BP Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishManaging Director10801090006
    BIELEFELD, Peter
    Guckingen
    Im Vordern Boden 25
    65558
    Germany
    Administrateur
    Guckingen
    Im Vordern Boden 25
    65558
    Germany
    GermanyGermanBusiness Executive138187960001
    BRACE, David Howard Rees
    Briar Lees
    Field Way Compton Down
    SO21 2AF Winchester
    Administrateur
    Briar Lees
    Field Way Compton Down
    SO21 2AF Winchester
    BritishAccountant33397020001
    CLARKE, James Richard
    Moorside House
    Moorside
    DT10 1HH Sturminster Newton
    Dorset
    Administrateur
    Moorside House
    Moorside
    DT10 1HH Sturminster Newton
    Dorset
    EnglandBritishSales Director62273580001
    KENT, Martin Robert
    Ridgebourne
    Front Street, East Garston
    RG17 7EU Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    Ridgebourne
    Front Street, East Garston
    RG17 7EU Hungerford
    Berkshire
    BritishDirector6391620007
    O'NEILL, Derek Patrick
    Oakley House, Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    Administrateur
    Oakley House, Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    EnglandBritishDirector87909140001
    RALPH, George Alexander
    Great North Road
    Eaton Ford
    PE19 7FP St. Neots
    367
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Great North Road
    Eaton Ford
    PE19 7FP St. Neots
    367
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector184012200001
    ZAMMIT, Patrick Laurent
    Avenue Du Manoir 38
    B-1180 Brussels
    1180
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Du Manoir 38
    B-1180 Brussels
    1180
    Belgium
    BelgiumFrenchBusiness Executive114841080001
    COURT BUSINESS SERVICES LTD
    209 Luckwell Road
    BS3 3HD Bristol
    Administrateur désigné
    209 Luckwell Road
    BS3 3HD Bristol
    900001650001

    QUILLER ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 oct. 2004
    Livré le 04 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each of the obligors to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 déc. 2003
    Livré le 12 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (The "Security Holder")
    Transactions
    • 12 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 avr. 1999
    Livré le 23 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 2 2 paisley road bournemouth dorset t/no;-DT140586. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 mars 1999
    Livré le 19 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a unit 1 2 paisley road bournemouth dorset.t/no DT138640.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 04 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    QUILLER ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 oct. 2011Dissolved on
    30 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Terence Getliffe
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Diane Elizabeth Hill
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0