TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRG EMAP DORMANT 4 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03640555
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ascential Group Limited The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRG EMAP DORMANT 1 LIMITED21 nov. 201221 nov. 2012
    DE HAVILLAND INFORMATION SERVICES LIMITED01 nov. 200501 nov. 2005
    DE HAVILLAND GLOBAL KNOWLEDGE DISTRIBUTION PLC24 sept. 199824 sept. 1998

    Quels sont les derniers comptes de TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP à C/O Ascential Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP le 14 déc. 2015

    1 pagesAD01

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced 24/09/2015
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2015

    État du capital au 01 avr. 2015

    • Capital: GBP 58,325.667
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2014

    État du capital au 02 avr. 2014

    • Capital: GBP 58,325.667
    SH01

    Cessation de la nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Gulliver en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Ms Amanda Jane Gradden en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed trg emap dormant 1 LIMITED\certificate issued on 21/11/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name21 nov. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name21 nov. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed de havilland information services LIMITED\certificate issued on 21/11/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name21 nov. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name21 nov. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP United Kingdom* le 01 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP United Kingdom* le 01 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Greater London House Hampstead Road London NW1 7EJ United Kingdom* le 01 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Emily Gestetner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de John Keith Gulliver en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOOI, Shanny
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    British129906110001
    GRADDEN, Amanda Jane
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish77425910003
    PAINTER, Duncan Anthony
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish132649960001
    BURNS, Conor David
    29 Granada Road
    Hedge End
    SO30 4AL Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    29 Granada Road
    Hedge End
    SO30 4AL Southampton
    Hampshire
    British48631060003
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Secrétaire
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    FREEMAN, Susanna
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    173152560001
    HAY, Helen Frances
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    Secrétaire
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    146423620001
    HOGG, Marianne Lisa
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    Secrétaire
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    British101383970002
    NAREBOR, Torugbene Eniyekeye
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    British120147010002
    WILLIAMS, Roderick John
    25 Cotswold Drive
    Linslade
    LU7 2UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secrétaire
    25 Cotswold Drive
    Linslade
    LU7 2UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British91529320002
    COSEC LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003850001
    AFRIYIE, Adam
    1 Sportsman's Cottage
    ME19 4PH West Malling
    Kent
    Administrateur
    1 Sportsman's Cottage
    ME19 4PH West Malling
    Kent
    British33706110002
    BRACKEN, William
    27a The Pantiles
    TN2 5TD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    27a The Pantiles
    TN2 5TD Tunbridge Wells
    Kent
    British61578900001
    BROWN, Philip
    Greydene
    Station Road, Woldingham
    CR3 7DD Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Greydene
    Station Road, Woldingham
    CR3 7DD Caterham
    Surrey
    United KingdomBritish70412460002
    CARTER, Derek Raymond Anthony
    Pinewych
    Vigo Road Fairseat
    TN15 7LR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Pinewych
    Vigo Road Fairseat
    TN15 7LR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish29959930002
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish40591070005
    GESTETNER, Emily Henrietta
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish138386390001
    GILBERTSON, David Stuart
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish10921820004
    GRAY, Tracey Marie
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritish130960400002
    GRIFFITHS, Ian Ward
    The Gate House 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE28 2JR Huntingdon
    Administrateur
    The Gate House 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE28 2JR Huntingdon
    United KingdomBritish99547790001
    GULLIVER, John Keith
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    United KingdomBritish170112360001
    HINDLEY, Martyn John
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritish134332760002
    RIDDICK, Graham Edward Galloway
    The Old Rectory
    Ashurst
    TN3 9TE Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Old Rectory
    Ashurst
    TN3 9TE Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish74206610001
    THOMAS, Henry
    140 Cottimore Lane
    KT12 2BN Walton-On-Thames
    Surrey
    Administrateur
    140 Cottimore Lane
    KT12 2BN Walton-On-Thames
    Surrey
    British114615800001
    WILLIAMS, Roderick John
    25 Cotswold Drive
    Linslade
    LU7 2UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Cotswold Drive
    Linslade
    LU7 2UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    United KingdomBritish91529320002
    CODIR LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003840001
    COSEC LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003850001

    TRG EMAP DORMANT 4 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 06 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0