OPAL METROPOLITAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPAL METROPOLITAN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03648104
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GIRATION LIMITED12 oct. 199812 oct. 1998

    Quels sont les derniers comptes de OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    47 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    47 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    45 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    44 pagesWU07

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY à 2 st Peters Square Manchester M2 3EY le 09 août 2017

    2 pagesAD01

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:re progress report 25/02/2015-24/02/2016
    41 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    51 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 31 janv. 2014

    46 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 sept. 2013

    62 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    117 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* le 18 mars 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 nov. 2012

    État du capital au 09 nov. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OPAL METROPOLITAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL METROPOLITAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 mai 2005
    Livré le 28 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Daisybank hall daisybank road victoria park manchester t/nos gm 812153 and gm 766209. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 24 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all estates or interests of the chargor in any f/h or l/h property including the f/h land and buildings on the south side of daisy bank road victoria park longsight manchester t/n GM812153 and the f/h land being ducie high school and 65 daisy bank road victoria park longsight manchester t/n GM766209. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties(The Securitytrustee)
    Transactions
    • 24 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge
    Créé le 01 nov. 2001
    Livré le 03 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under the terms of the loan agreement dated 5TH july 2000 or otherwise and all monies due under the terms of the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed legal charge phase b daisy bank hall (being blocks k/a b & c) daisy bank road victoria park longsight manchester t/no.766209.
    Personnes ayant droit
    • Creditforce Limited
    Transactions
    • 03 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as ducie high school and 65 daisy bank road victoria park longsight, manchester greater manchester title number GM766209.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 05 juil. 2000
    Livré le 14 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Property namely phase a daisy bank hall (being blocks a, d and e) daisy bank road longsight manchester t/no: GM812153.
    Personnes ayant droit
    • Creditforce Limited
    Transactions
    • 14 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 sept. 1999
    Livré le 17 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a ducie high school and 65 daisy bank road longsight manchester t/no;-GM766209 together with goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 sept. 1999
    Livré le 15 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as land and buildings on the south side of daisy bank road, victoria park longsight title number GM812153. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 15 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 août 1999
    Livré le 13 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 13 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 mai 1999
    Livré le 06 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from watkin jones & son or by the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Part of that f/h land k/a ducie high school and 65 daisy bank road longsight manchester togethrer with goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 06 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OPAL METROPOLITAN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 févr. 2014Administration ended
    12 mars 2013Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DateType
    25 févr. 2014Commencement of winding up
    13 sept. 2019Conclusion of winding up
    19 févr. 2020Dissolved on
    10 févr. 2014Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0