NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED

NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNHP SECURITIES NO. 7 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03655685
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o NHP MANAGEMENT LTD
    Liberty House
    222 Regent Street
    W1B 5TR London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEGISLATOR 1400 LIMITED26 oct. 199826 oct. 1998

    Quels sont les derniers comptes de NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2011

    État du capital au 02 mars 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de 25 Hanover Square London W1S 1JF le 15 janv. 2010

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Paul Hugh Thompson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Grant en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    Comptes établis au 30 sept. 2006

    42 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Secrétaire
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Administrateur
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    THOMPSON, Paul Hugh
    St. Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish100977220001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Secrétaire
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secrétaire
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Secrétaire
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secrétaire
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secrétaire
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Secrétaire
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    English51896650001
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Administrateur
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Administrateur
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BERGBAUM, Arthur
    23 Pine Grove
    Totteridge
    N20 8LB London
    Administrateur
    23 Pine Grove
    Totteridge
    N20 8LB London
    British1770100001
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Administrateur
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Administrateur
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Administrateur
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Administrateur
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Administrateur
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Administrateur
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Administrateur
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Administrateur
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    NICHOLSON, Daniel Christopher
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    Administrateur
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    EnglandBritish77890230001
    PICKERSGILL, Dominic James
    72 Stafford Street
    NR2 3BG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    72 Stafford Street
    NR2 3BG Norwich
    Norfolk
    British60834690001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Administrateur
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglandEnglish51896650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Administrateur
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003

    NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A security deed
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 30 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch
    Transactions
    • 30 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 12 déc. 2006
    Livré le 21 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 21 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0