FIRST RUNCORN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRST RUNCORN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03657457
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRST RUNCORN LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe FIRST RUNCORN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ground Floor, Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRST RUNCORN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORDGATE RUNCORN LIMITED20 févr. 200120 févr. 2001
    EASTER CAPITAL RUNCORN LIMITED10 févr. 199910 févr. 1999
    PRECIS (1695) LIMITED28 oct. 199828 oct. 1998

    Quels sont les derniers comptes de FIRST RUNCORN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRST RUNCORN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2016

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Canal Mill Botany Bay Chorley Lancashire PR6 9AF à Ground Floor, Seneca House Links Point Amy Johnson Way Blackpool Lancashire FY4 2FF le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 sept. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Claire Caroline Sharp en tant que directeur le 09 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy John Peter Knowles en tant que directeur le 09 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2015

    8 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2015 au 30 janv. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2015

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2013

    État du capital au 30 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de William Dixon en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2011

    9 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed fordgate runcorn LIMITED\certificate issued on 19/10/10
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name19 oct. 2010

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Qui sont les dirigeants de FIRST RUNCORN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    BritishProperty Director141979130001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountant71862660002
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Secrétaire
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    JACOBS, Simon
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    British74462020001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Secrétaire
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARBER, Martin
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    Administrateur
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    BritishCompany Director35534320001
    CORAL, Lynda Sharon
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    BritishChartered Accountant34029880002
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Administrateur
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director136501510001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritishFinancial Director85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Administrateur
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishDirector33274370003
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Administrateur
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritishCompany Secretary59962430002
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishProperty Director141979130001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Surveyor109810150001
    TAYLOR RESTELL, Ian Miles
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    Administrateur
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    BritishSurveyor56776370003
    WECHSLER, Michael
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Administrateur
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    EnglandBritishAccountant12071850001
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Administrateur
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    BritishSolicitor47611200001
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishDirector110948700001

    FIRST RUNCORN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of legally mortgaged property please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutche Bank Ag as Security Trustee
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental debenture
    Créé le 07 juin 2001
    Livré le 08 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) the property owners (as defined) and/or the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    F/H property situate on the south side of warrington road and land on the east side of manor park avenue runcorn CH302580.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limitedthe Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 08 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party debenture
    Créé le 13 févr. 2001
    Livré le 22 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from sandrim holdings limited (the borrower), the property owners (as defined) and/or the company (formerly known as easter capital runcorn limited) to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the security trustee) from time to time under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 22 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 25 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the liabilities of capital & regional properties PLC (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land k/a land on the south side of warrington road and land on the east side of manor park runcorn cheshire.t/no CH302580 or its proceeds of sale fixed charge the plant machinery and fixtures and fittings furniture and equipment implements and utensils.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 25 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FIRST RUNCORN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2016Commencement of winding up
    10 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Ian Williamson
    Ground Floor Seneca House Links Point Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    practitioner
    Ground Floor Seneca House Links Point Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0