FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED

FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03657772
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ground Floor, Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORDGATE ESTATES LIMITED20 févr. 200120 févr. 2001
    EASTER CAPITAL PORTFOLIO LIMITED10 févr. 199910 févr. 1999
    PRECIS (1694) LIMITED28 oct. 199828 oct. 1998

    Quels sont les derniers comptes de FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2016

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Canal Mill Botany Bay Chorley Lancashire PR6 9AF à Ground Floor, Seneca House Links Point Amy Johnson Way Blackpool Lancashire FY4 2FF le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 sept. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Claire Caroline Sharp en tant que directeur le 09 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy John Peter Knowles en tant que directeur le 09 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2015

    8 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2015 au 30 janv. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2015

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2013

    État du capital au 30 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2012

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de William Dixon en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2011

    9 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed fordgate estates LIMITED\certificate issued on 02/11/10
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name02 nov. 2010

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2010

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish71862660002
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Secrétaire
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    JACOBS, Simon
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    British74462020001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Secrétaire
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARBER, Martin
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    Administrateur
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    British35534320001
    CORAL, Lynda Sharon
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    British34029880002
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Administrateur
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritish136501510001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritish85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Administrateur
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish33274370003
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Administrateur
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritish59962430002
    SHARP, Carrie
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish124558490001
    SHARP, Claire Caroline
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    Administrateur
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    EnglandBritish141979130001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    TAYLOR RESTELL, Ian Miles
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    Administrateur
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    British56776370003
    WECHSLER, Michael
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Administrateur
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    EnglandBritish12071850001
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Administrateur
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    British47611200001
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish110948700001

    FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of legally mortgaged property please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutche Bank Ag as Security Trustee
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental debenture
    Créé le 07 juin 2001
    Livré le 08 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) the property owners (as defined ) and /or the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The properties k/a 1-7 lynton road swinton t/n WT5533, north cheshire trading estate penton wyrall t/n MS288604.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limitedthe Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 08 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party debenture
    Créé le 13 févr. 2001
    Livré le 22 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from sandrim holdings limited (the borrower), the property owners (as defined) and/or the company (formerly known as easter capital portfolio limited) to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the security trustee) from time to time under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 22 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Units 1,2 and 3 conway street hove t/n ESX169969 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    F/H land being units 1-7 lynton road swindon t/n WT5533 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    F/H land being 11 12 and 14 (inclusive) ravenhurst court and 1-12 (inclusive) and 14,15 and 16 gawsworth court risley road risley warrington chaeshire t/n CH320470 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    All that l/h land and buildings to the south of woodchurch road birkenhead t/n MS288604 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    F/H land being unit 1 euroway estate commondale way bierley t/n WYK419929 f/h land on the east side of commondale way oakenshaw WYK105459 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    All that f/h land being land and buildings on the north east side of ashfield way farnley t/n WYK69344 all monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and portfolio limited ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Freehold land being units 1,2,3,4 and 5 south hampshire industrial estate totton t/n HP404430 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Brèves mentions
    All that f/h land being land and buildings on the south east side of ripley drive normanton t/n WYK547370 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2016Commencement of winding up
    10 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Ian Williamson
    Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    practitioner
    Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0