TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED

TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03659481
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Milsted Langdon Llp Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NP Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MB167 LIMITED30 oct. 199830 oct. 1998

    Quels sont les derniers comptes de TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 août 2023

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 août 2022

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 août 2021

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 août 2020

    12 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 2a Herongate Charnham Park Hungerford Berkshire RG17 0YU à C/O Milsted Langdon Llp Freshford House Redcliffe Way Bristol BS1 6NP le 10 sept. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 août 2019

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 036594810013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 036594810012 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 036594810011 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 juin 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The premium account be cancelled 03/06/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Kerridge Commercial Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 oct. 2016

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2017

    18 pagesAA

    Statuts

    13 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    17 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 036594810013, créée le 25 avr. 2018

    18 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEDFORD, Nigel Jonathan
    Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NP Bristol
    C/O Milsted Langdon Llp
    Administrateur
    Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NP Bristol
    C/O Milsted Langdon Llp
    EnglandBritish61366250001
    BENDELOW, Ian Barrie
    Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NP Bristol
    C/O Milsted Langdon Llp
    Administrateur
    Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NP Bristol
    C/O Milsted Langdon Llp
    EnglandBritish164135310001
    JOHNS, Michael David
    76 Dukes Ride
    RG45 6DN Crowthorne
    Berkshire
    Secrétaire
    76 Dukes Ride
    RG45 6DN Crowthorne
    Berkshire
    British126880050001
    MITCHELL, David James
    Town Farm
    NN13 5YS Mixbury
    Yard End 1
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Town Farm
    NN13 5YS Mixbury
    Yard End 1
    Northamptonshire
    British195535420001
    VIDAL, Eric Jean-Pierre
    Herongate
    Charnham Park
    RG17 0YU Hungerford
    2a
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Herongate
    Charnham Park
    RG17 0YU Hungerford
    2a
    Berkshire
    United Kingdom
    151558240001
    MB SECRETARIES LIMITED
    C/O Morgan Cole 167 Fleet Street
    EC4A 2JB London
    Secrétaire
    C/O Morgan Cole 167 Fleet Street
    EC4A 2JB London
    63289940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Christopher Robert
    Norris Acre
    Hinton-In-The-Hedges
    NN13 5NN Brackley
    10
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Norris Acre
    Hinton-In-The-Hedges
    NN13 5NN Brackley
    10
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritish153135790001
    CRESWELL, Michael Elliott
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish53686660003
    EVANS, Michael Anthony Grant
    The Belfry House Painshill
    Portsmouth Road
    KT11 1DJ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    The Belfry House Painshill
    Portsmouth Road
    KT11 1DJ Cobham
    Surrey
    British50681780002
    FORTIN, Richard Chalmers Gordon
    5 Dealtry Road
    Putney
    SW15 6NL London
    Administrateur
    5 Dealtry Road
    Putney
    SW15 6NL London
    British31479720001
    HEWITT, Malcolm Andrew
    Chantry Cottage
    Front Street
    RG17 7HN East Garston
    Berkshire
    Administrateur
    Chantry Cottage
    Front Street
    RG17 7HN East Garston
    Berkshire
    British109017130002
    JOHNS, Michael David
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish126880050001
    LUSTY, Peter
    Nesta Stocking Lane
    Hughenden Valley
    HP14 4NE High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Nesta Stocking Lane
    Hughenden Valley
    HP14 4NE High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish154640340001
    MASOM, Grant Anthony
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Regatta Place
    Marlow Road
    SL8 5TD Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46157710001
    MITCHELL, David James
    Town Farm
    NN13 5YS Mixbury
    Yard End 1
    Northamptonshire
    Administrateur
    Town Farm
    NN13 5YS Mixbury
    Yard End 1
    Northamptonshire
    EnglandBritish195535420001
    SANE, Jack
    7 Holtspur Close
    HP9 1DP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Holtspur Close
    HP9 1DP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish54036420001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MB INCORPORATIONS LIMITED
    C/O Morgan Cole
    167 Fleet Street
    EC4A 2JB London
    Administrateur
    C/O Morgan Cole
    167 Fleet Street
    EC4A 2JB London
    40914750002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Herongate
    RG17 0YU Hungerford
    Charnham Park
    England
    04 oct. 2016
    Herongate
    RG17 0YU Hungerford
    Charnham Park
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07090521
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 avr. 2018
    Livré le 10 mai 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lucid Trustee Services Limited
    Transactions
    • 10 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 23 juil. 2015
    Livré le 31 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None in respect of this company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank as Security Agent
    Transactions
    • 31 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 févr. 2015
    Livré le 11 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank (As Security Agent)
    Transactions
    • 11 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 14 oct. 2011
    Livré le 21 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each grantor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited
    Transactions
    • 21 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 14 oct. 2011
    Livré le 21 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each grantor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited
    Transactions
    • 21 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 oct. 2011
    Livré le 19 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a fawley house marlow road bourne end buckinghamshire t/no BM237408 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 18 août 2008
    Livré le 22 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 15 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Stramongate Assets PLC
    Transactions
    • 15 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 05 mars 1999
    Livré le 18 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as mb 167 limited to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All money including bonuses that has accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and all the company's rights and interest in policy NORNF00057410A.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 05 mars 1999
    Livré le 18 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as mb 167 limited to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All money including bonuses that has accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and all the company's rights and interest in policy NORNF00057406A.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 05 mars 1999
    Livré le 18 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as mb 167 limited to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All money including bonuses that has accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and all the company's rights and interest in policy NORNF00057408A.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 16 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as mb 167 limited to the chargee in respect of loan stock for the £2,450,000 9 per cent secured subordinated loan stock 2002-2005 on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Sand Aire Investments PLC
    Transactions
    • 16 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 10 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TIS SOFTWARE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 mars 2024Due to be dissolved on
    23 août 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Ashley Rowe
    Freshford House Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Avon
    practitioner
    Freshford House Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Avon
    Timothy Alexander Close
    Milsted Langdon
    Winchester House
    TA1 2UH Deane Gate Avenue
    Taunton Somerset
    practitioner
    Milsted Langdon
    Winchester House
    TA1 2UH Deane Gate Avenue
    Taunton Somerset

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0