NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03660222 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED ?
Adresse du siège social | Kendal Leisure Centre Burton Road LA9 7HX Kendal Cumbria England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Nomination de Mr Neil Edward Golightly en tant que secrétaire le 19 févr. 2018 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Paul Andrew Robinson en tant que secrétaire le 29 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Nicholas Paul White en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Ann Slater Wheat en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Gordon Dixon Scorer en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Ronald James Kenyon en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Peter Frederic Johnstone en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Ncl House Hexham Business Park Burn Lane Hexham Northumberland NE46 3RU à Kendal Leisure Centre Burton Road Kendal Cumbria LA9 7HX le 06 avr. 2017 | 1 pages | AD01 | ||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||
Nomination de Mr Paul Andrew Robinson en tant que secrétaire le 12 janv. 2017 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de David Anthony Weakley en tant que secrétaire le 12 janv. 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 036602220002 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 7 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Graham Charles Randell en tant que directeur le 17 mai 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Margaret Patricia Reed en tant que directeur le 17 mai 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||
Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2016 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||
Nomination de Mr David Anthony Weakley en tant que secrétaire le 17 nov. 2015 | 2 pages | AP03 | ||
Qui sont les dirigeants de NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLIGHTLY, Neil Edward | Secrétaire | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | 243947380001 | |||||||
ARGENT, Jonathan David | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | United Kingdom | British | Chief Executive | 119728720001 | ||||
HORNER, Christopher | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | England | British | Management Consultant | 88712090001 | ||||
JAMES, Graeme Martin | Secrétaire | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | 192911480001 | |||||||
MAUDE, John Edward | Secrétaire | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | British | Director | 63776950001 | |||||
ROBINSON, Paul Andrew | Secrétaire | Hexham Business Park, Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House England | 222566290001 | |||||||
WEAKLEY, David Anthony | Secrétaire | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | 203280260001 | |||||||
DICKINSON DEES | Secrétaire désigné | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
BRADBURY, Neil John, Councillor | Administrateur | 52 Cranbrook Drive NE42 6QF Prudhoe Northumberland | Uk | British | Investment Officer | 98358900001 | ||||
CARE, Timothy James | Administrateur désigné | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
CORBETT, Brian Hall, Councillor | Administrateur | East Otterburn Farm Otterburn NE19 1NP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Farmer | 63774920001 | |||||
DONALDSON, Karen | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | United Kingdom | British | Business Development Manager | 173287820001 | ||||
HALLIWELL, Peter Robert | Administrateur | 7a Shaftoe Leazes Hexham NE46 3DF Northumerland | British | Leisure Manager | 63776840002 | |||||
JOHNSTONE, Peter Frederic | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | United Kingdom | British | Retired | 116748490001 | ||||
KENYON, Ronald James | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | United Kingdom | British | Retired | 84516940001 | ||||
LAMB, Darren | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | United Kingdom | British | Operations Manager | 86140050001 | ||||
LEWIS, Robert Alan | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | England | British | Solicitor | 34016320004 | ||||
MAUDE, John Edward | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | United Kingdom | British | Director | 63776950001 | ||||
OLDHAM, Nicholas | Administrateur | 11 Pearsons Terrace NE46 3DZ Hexham Northumberland | British | Business Development | 63774970001 | |||||
PARKER, John Richard | Administrateur | 8 Burnside NE66 3JQ Longhoughton Northumberland | British | Sales Manager | 77956760003 | |||||
PARKER, John Richard | Administrateur | PO BOX 63 NE66 3WA Alnwick Northumberland | British | Entertainer | 77956760002 | |||||
PHILLIPS, Anton Maurice | Administrateur | The Lodge Langley Castle Langley On Tyne NE47 5LU Hexham Northumberland | British | Hotel Manager | 73901820001 | |||||
RANDELL, Graham Charles | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | United Kingdom | British | Retired | 103316990002 | ||||
REED, Margaret Patricia | Administrateur | Hexham Business Park Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House Northumberland | England | British | Fundraising Regional Manager | 115776420001 | ||||
SCORER, Gordon Dixon | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | United Kingdom | British | Retired | 126325250001 | ||||
STYRING, Roger | Administrateur | 6 Lealands Lesbury NE66 3QN Alnwick Northumberland | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 115780620001 | ||||
WHEAT, Ann Slater | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | England | British | Business Advisor | 108675530001 | ||||
WHITE, Nicholas Paul | Administrateur | Burton Road LA9 7HX Kendal Kendal Leisure Centre Cumbria England | United Kingdom | British | Investment Manager | 113787370001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Country Leisure | 06 avr. 2016 | Hexham Business Park, Burn Lane NE46 3RU Hexham Ncl House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
NORTH COUNTRY LEISURE (TRADING) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 26 nov. 2014 Livré le 10 déc. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 déc. 2000 Livré le 19 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0