SHUKCO 322 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHUKCO 322 LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03661159
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHUKCO 322 LTD ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SHUKCO 322 LTD ?

    Adresse du siège social
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHUKCO 322 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SITA MR SHEFFIELD LIMITED05 sept. 200705 sept. 2007
    EASCO (SHEFFIELD) LIMITED11 déc. 199811 déc. 1998
    ALLIEDCLEAR LIMITED04 nov. 199804 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de SHUKCO 322 LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SHUKCO 322 LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SHUKCO 322 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de David Courtenay Palmer-Jones en tant que directeur le 03 juin 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christophe Andre Bernard Chapron le 01 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed sita mr sheffield LIMITED\certificate issued on 14/07/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 juil. 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2014

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2013

    État du capital au 09 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Appointed auditors 22/09/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Palmer-Jones le 01 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de SHUKCO 322 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Mark Hedley
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British135450680001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500006
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Secrétaire
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    British114403390001
    MCKENA-MAYES, Graham Arthur
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    British91435430003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BILLIG, Neil Jonathan
    5 Staitheway Road
    Wroxham
    NR12 8TH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    5 Staitheway Road
    Wroxham
    NR12 8TH Norwich
    Norfolk
    British15677460004
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Administrateur
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    EnglandBritish114403390001
    HARRISON, Richard
    15 Dalewood Avenue
    Beauchief
    S8 0EG Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    15 Dalewood Avenue
    Beauchief
    S8 0EG Sheffield
    South Yorkshire
    British82759320001
    HJORT, Per-Anders
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Administrateur
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Swedish121832680001
    MARKELL, Brian Stuart
    Bridge House Church Lane
    Ravenfield
    S65 4NG Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    Bridge House Church Lane
    Ravenfield
    S65 4NG Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish11150720001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    SERRUYS, Andre Paul
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    British33476230001
    WINSTONE, Steven Dominic
    The Old Bank
    20 High Street Beighton
    S20 1HA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Old Bank
    20 High Street Beighton
    S20 1HA Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish125330840001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SHUKCO 322 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 sept. 2005
    Livré le 09 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2003
    Livré le 31 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 08 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2001
    Créé le 29 mai 2002
    Livré le 01 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 22 déc. 1998
    Livré le 30 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0