COMPUTER SOFTWARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPUTER SOFTWARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03665527
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GUILDFORD MIDCO 2 LIMITED12 mai 201012 mai 2010
    COMPUTER SOFTWARE LIMITED12 juil. 199912 juil. 1999
    COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED26 mars 199926 mars 1999
    MAILCLEAR LIMITED11 nov. 199811 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2013

    État du capital au 12 nov. 2013

    • Capital: GBP 464,523.75
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    7 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012

    3 pagesCH01

    Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* le 14 mai 2012

    1 pagesAD01

    Statuts

    26 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de COMPUTER SOFTWARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951890001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Secrétaire
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Secrétaire
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    British68788350001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British69845130001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAGGS, Michael Vincent
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    Administrateur
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    United KingdomBritish25974780001
    BARNES, Kenneth Roy
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    Administrateur
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    British33463930001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritish158261930001
    CROSS, Neil Edward
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    Administrateur
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    EnglandBritish26042290002
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Administrateur
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish68788350001
    HOLLAND, Christopher
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    Administrateur
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    British77338810001
    JACKSON, Glenn Thomas
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    EnglandBritish38721150004
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    Administrateur
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    United KingdomBritish40521530001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    LOWE, David Andrew
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    Administrateur
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    British10441050001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    UkBritish69845130001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PINNING, Stephen Peter
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    Administrateur
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    British14848160001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, David John
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish91573380001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Administrateur
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330002
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Administrateur
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    CLARKS NOMINEES LIMITED
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    38350670001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.,London as Security Trustee
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 juil. 2004
    Livré le 07 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the security trsutee and/or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Elderstreet Capital Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 12 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 10 mai 2000
    Livré le 12 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £45,000 held on an account with the bank together with interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 déc. 1998
    Livré le 23 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2014Commencement of winding up
    05 nov. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0