FOOTAGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFOOTAGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03667358
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FOOTAGE LIMITED ?

    • Activités photographiques n.c.a. (74209) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe FOOTAGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Hilton Consulting Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FOOTAGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IMAGE SOURCE LIMITED09 nov. 199809 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de FOOTAGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour FOOTAGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 036673580008 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    6 pagesAA

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 119 the Hub 300 Kensal Road London W10 5BE à C/O Hilton Consulting Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road London W10 5BN le 08 sept. 2021

    1 pagesAD01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 août 2020

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Notification de Michael Edward Wilson Jackson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    2 pagesPSC01

    Cessation de David Edward Bloom en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    1 pagesPSC07

    Cessation de Anthony Marc Harris en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mr Michael Edward Wilson Jackson en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Marc Harris en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Edward Bloom en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FOOTAGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROEBUCK, John
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    United Kingdom
    British164828420001
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    Administrateur
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector40521530018
    VAUGHAN, Christina Stella Maria
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Administrateur
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    EnglandBritishDirector45818340007
    VAUGHAN, Christina Stella Maria
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Secrétaire
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    BritishDirector45818340006
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLACKWELL, Martin Lewis
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Administrateur
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    United KingdomBritishNone158152370001
    BLOOM, David Edward
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    United Kingdom
    Administrateur
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director68096240005
    CHALONER, Thomas Eric
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Administrateur
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    EnglandBritishConsultant59994380002
    GROSSART, Duncan Howard
    18 Linden Avenue
    NW10 5QT London
    Administrateur
    18 Linden Avenue
    NW10 5QT London
    United KingdomBritishDirector165126200001
    HARRIS, Anthony Marc
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    United Kingdom
    Administrateur
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director121689870001
    LOUIS LEE-GRAHAM, John
    The Chimes Wix Hill Close
    West Horsley
    KT24 6EE Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    The Chimes Wix Hill Close
    West Horsley
    KT24 6EE Leatherhead
    Surrey
    BritishDirector21504370003
    NOIK, Darryl Sean
    12 Foxmore Street
    SW11 4PU London
    Administrateur
    12 Foxmore Street
    SW11 4PU London
    EnglandBritishChartered Accountant62951950001
    SANDERSON, Craig
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Administrateur
    Great Pulteney Street
    W1F 9NZ London
    41
    England
    BritishChartered Accountant117820760001
    WEINSTEIN, Harvey
    106 Kenozia Lake Road
    Shokan
    New York Ny 12481
    Usa
    Administrateur
    106 Kenozia Lake Road
    Shokan
    New York Ny 12481
    Usa
    Us CitizenCompany Director49886940001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FOOTAGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Michael Edward Wilson Jackson
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    31 janv. 2018
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr David Edward Bloom
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    01 mai 2016
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Anthony Marc Harris
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    01 mai 2016
    300 Kensal Road
    W10 5BE London
    119 The Hub
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Ms Christina Stella Maria Vaughan
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    01 mai 2016
    Studio 133, Canalot Studios
    222 Kensal Road
    W10 5BN London
    C/O Hilton Consulting
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    FOOTAGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 mars 2016
    Livré le 24 mars 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 juil. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Cross-guarantee and debenture
    Créé le 21 oct. 2011
    Livré le 27 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Income & Growth Vct PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 08 juil. 2011
    Livré le 15 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts now and in the future credited to account designation 25787047 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 27 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 27 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 08 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 juil. 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2003
    Livré le 10 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Trivest Vct PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mars 2002
    Livré le 14 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0