FOOTAGE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FOOTAGE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03667358 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FOOTAGE LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Hilton Consulting Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road W10 5BN London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FOOTAGE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour FOOTAGE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 036673580008 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 119 the Hub 300 Kensal Road London W10 5BE à C/O Hilton Consulting Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road London W10 5BN le 08 sept. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Notification de Michael Edward Wilson Jackson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Cessation de David Edward Bloom en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Anthony Marc Harris en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Edward Wilson Jackson en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Marc Harris en tant que directeur le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Edward Bloom en tant que directeur le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2016 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FOOTAGE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROEBUCK, John | Secrétaire | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 United Kingdom | British | 164828420001 | ||||||
JACKSON, Michael Edward Wilson | Administrateur | Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road W10 5BN London C/O Hilton Consulting United Kingdom | England | British | Director | 40521530018 | ||||
VAUGHAN, Christina Stella Maria | Administrateur | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 England | England | British | Director | 45818340007 | ||||
VAUGHAN, Christina Stella Maria | Secrétaire | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 England | British | Director | 45818340006 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BLACKWELL, Martin Lewis | Administrateur | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 England | United Kingdom | British | None | 158152370001 | ||||
BLOOM, David Edward | Administrateur | 300 Kensal Road W10 5BE London 119 The Hub United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 68096240005 | ||||
CHALONER, Thomas Eric | Administrateur | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 England | England | British | Consultant | 59994380002 | ||||
GROSSART, Duncan Howard | Administrateur | 18 Linden Avenue NW10 5QT London | United Kingdom | British | Director | 165126200001 | ||||
HARRIS, Anthony Marc | Administrateur | 300 Kensal Road W10 5BE London 119 The Hub United Kingdom | England | British | Company Director | 121689870001 | ||||
LOUIS LEE-GRAHAM, John | Administrateur | The Chimes Wix Hill Close West Horsley KT24 6EE Leatherhead Surrey | British | Director | 21504370003 | |||||
NOIK, Darryl Sean | Administrateur | 12 Foxmore Street SW11 4PU London | England | British | Chartered Accountant | 62951950001 | ||||
SANDERSON, Craig | Administrateur | Great Pulteney Street W1F 9NZ London 41 England | British | Chartered Accountant | 117820760001 | |||||
WEINSTEIN, Harvey | Administrateur | 106 Kenozia Lake Road Shokan New York Ny 12481 Usa | Us Citizen | Company Director | 49886940001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FOOTAGE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Michael Edward Wilson Jackson | 31 janv. 2018 | Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road W10 5BN London C/O Hilton Consulting United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr David Edward Bloom | 01 mai 2016 | 300 Kensal Road W10 5BE London 119 The Hub | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Anthony Marc Harris | 01 mai 2016 | 300 Kensal Road W10 5BE London 119 The Hub | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Christina Stella Maria Vaughan | 01 mai 2016 | Studio 133, Canalot Studios 222 Kensal Road W10 5BN London C/O Hilton Consulting United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
FOOTAGE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 mars 2016 Livré le 24 mars 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Cross-guarantee and debenture | Créé le 21 oct. 2011 Livré le 27 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 08 juil. 2011 Livré le 15 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All amounts now and in the future credited to account designation 25787047 with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 19 juil. 2006 Livré le 27 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 02 sept. 2005 Livré le 08 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 juil. 2003 Livré le 04 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 juin 2003 Livré le 10 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 mars 2002 Livré le 14 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0