ASTRON CLINICA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASTRON CLINICA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03671031
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASTRON CLINICA LIMITED ?

    • (7260) /

    Où se situe ASTRON CLINICA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASTRON CLINICA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPTISCAN LIMITED20 nov. 199820 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de ASTRON CLINICA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour ASTRON CLINICA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 déc. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    14 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 juin 2011

    5 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 mai 2010

    18 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg Llp 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL le 22 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 nov. 2009

    15 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    12 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    25 pages2.17B

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    14 pages395

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    17 pages363a

    legacy

    1 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    legacy

    1 pages288b

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2007

    22 pagesAA

    legacy

    12 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    12 pages363s

    Qui sont les dirigeants de ASTRON CLINICA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOSS, Suzanne Claire
    31 Youngman Avenue
    Histon
    CB24 9HP Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    31 Youngman Avenue
    Histon
    CB24 9HP Cambridge
    Cambridgeshire
    British119114820001
    AL GOSAIBI, Sattam Sulaiman Abdulmohsin
    Villa 186
    Road 2206
    West Riffa
    922
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Villa 186
    Road 2206
    West Riffa
    922
    Kingdom Of Bahrain
    Saudi ArabianBanker105186990001
    BROOKING, Anne Gwyneth, Ms.
    Longview
    Mill Field
    CB24 8RA Cottenham
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Longview
    Mill Field
    CB24 8RA Cottenham
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCeo91358980001
    COTTON, Symon D'Oyly, Dr
    5 Williams Close
    SG19 3QS Great Gransden
    Cambs
    Administrateur
    5 Williams Close
    SG19 3QS Great Gransden
    Cambs
    BritishChief Scientist66707470002
    GREASLEY, Martin John
    Arch Farm
    Woolpit Road Norton
    IP31 3LX Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Arch Farm
    Woolpit Road Norton
    IP31 3LX Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishAccountant150707540001
    MALIK, Adnan
    Flat 12, Building 121 PO BOX 2066
    Manama
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Flat 12, Building 121 PO BOX 2066
    Manama
    Kingdom Of Bahrain
    BritishDirector126554820001
    MERCER, Paul Andrew
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Villa 1 Gate 1354
    Road 7520
    Janabiyah 575
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainBritishBanker104845840001
    ROTHMAN, Martin Terry, Professor
    160 Basin Approach
    Limehouse Basin
    E14 7JJ London
    Administrateur
    160 Basin Approach
    Limehouse Basin
    E14 7JJ London
    United KingdomBritishCardiologist65449260002
    ET CAPITAL DIRECTORS LIMITED
    St John's Innovation Centre
    Cowley Road
    CB4 0WS Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    St John's Innovation Centre
    Cowley Road
    CB4 0WS Cambridge
    Cambridgeshire
    98543800001
    CANE, Michael Roger
    9 Keats Close
    SG8 5AU Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 Keats Close
    SG8 5AU Royston
    Hertfordshire
    BritishDesign Consultant56776860003
    MAYFIELD, John Michael
    The Mount
    The Mount, Toft
    CB3 7RL Cambridge
    Cambs
    Secrétaire
    The Mount
    The Mount, Toft
    CB3 7RL Cambridge
    Cambs
    BritishCfo112466090001
    VERNEY, Jean Margaret
    40 School Lane
    Toft
    CB3 7RE Cambridge
    Secrétaire
    40 School Lane
    Toft
    CB3 7RE Cambridge
    British68063140001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    AL KHAYYAT, Abdulhakeem Yacoob
    Villa 506 Road 2113
    Busaiteen 221
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    Villa 506 Road 2113
    Busaiteen 221
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainiBanker General Manager108243300001
    ALMAJTHOOB, Salahuddin Abdulmonem Majthoob, Dr
    House 166,
    Road 1303,
    East Riffa 913
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    House 166,
    Road 1303,
    East Riffa 913
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainiBanker104846080001
    BEADMAN, Michael Andrew
    64a High Street
    Guilden Morden
    SG8 0JS Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    64a High Street
    Guilden Morden
    SG8 0JS Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishDesign Consultant56776990001
    BOUCHER, Charles Andre
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    Administrateur
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    United KingdomBritishFinance Director2323080001
    CANE, Michael Roger
    9 Keats Close
    SG8 5AU Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Keats Close
    SG8 5AU Royston
    Hertfordshire
    BritishDesign Consultant56776860003
    GAVED, Matthew, Dr
    29 Bristol Gardens
    W9 2JQ London
    Administrateur
    29 Bristol Gardens
    W9 2JQ London
    United KingdomBritishBusiness Consultant14707490001
    MALLINSON, James Hugh Charteris
    Pin Farm House
    South Hinksey
    OX1 5BB Oxford
    Administrateur
    Pin Farm House
    South Hinksey
    OX1 5BB Oxford
    United KingdomBritishBusiness Director70468310002
    MCCONCHIE, Stuart Bruce
    Barr Field House
    Fowlmere
    SG8 7SH Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Barr Field House
    Fowlmere
    SG8 7SH Royston
    Hertfordshire
    AustralianConsultant66707620001
    MCGREGOR, Douglas Hugh
    Titcombe Cottage
    Gravel Road, Binfield Heath
    RG9 4LT Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Titcombe Cottage
    Gravel Road, Binfield Heath
    RG9 4LT Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector104312400001
    MUNFAREDI, Sharif Ebrahim Abdulla
    House No 70
    Shakeeb Garden
    Janusan - Budaiya Road
    Kingdom Of Bahrain
    Administrateur
    House No 70
    Shakeeb Garden
    Janusan - Budaiya Road
    Kingdom Of Bahrain
    BahrainiBanker104845740001
    TERRY, Stephen John
    3 The Bowsprit
    KT11 2RQ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    3 The Bowsprit
    KT11 2RQ Cobham
    Surrey
    BritishBusiness Development Director116646070001
    WILKINSON, John Balfour
    Broadlands
    Spring Road
    AL5 3PP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Broadlands
    Spring Road
    AL5 3PP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director77898330001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    ASTRON CLINICA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 avr. 2009
    Livré le 27 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Kuwait Finance House (Bahrain) B.S.C.(C) (the Beneficiary)
    Transactions
    • 27 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage of patents
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    The patents country australia,priority date 19.11.96 application date 19.11.97 title,skin histology measurement publication no.49615/97 For further details of the patents charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Qtp and Oxford Technology 2 Vct PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patent assignment
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    The patent priority date 19.11.96 application date 19.11.97 title,skin histology measurement publication no.9910980.3.
    Personnes ayant droit
    • Qtp and Oxford Technology 2 Vct PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patent assignment
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    The patent priority date 19.11.96 application date 19.11.97 title skin histology measurement application no 314 751.
    Personnes ayant droit
    • Qtp and Oxford Technology 2 Vct PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patent assignment
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    The patent priority date 19.11.96 application date 19.11.97 title:skin histology measurement application no.97912388.2.
    Personnes ayant droit
    • Qtp and Oxford Technology 2 Vct PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patent assignment
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 9 august 2001
    Brèves mentions
    The patent:priority date 6.5.00 application date 6.5.00 title:apparatus & method for analysing skin histolgy ,application no.pct application dated 6.5.01 based on GB0010888.6 (Agent ref 2127-P101-wo õ !).
    Personnes ayant droit
    • Qtp and Oxford Technology 2 Vct PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASTRON CLINICA LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2009Administration started
    02 juin 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Richard Dixon Fleming
    2 Cornwall Street
    Birmingham
    B3 2DL
    practitioner
    2 Cornwall Street
    Birmingham
    B3 2DL
    2
    DateType
    02 juin 2010Commencement of winding up
    06 mai 2012Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0