HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED

HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03671042
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Eastcheap
    EC3M 1BD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEALTHCARE INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE SERVICES LIMITED30 déc. 199830 déc. 1998
    COMPLETE MEDICAL SERVICES LIMITED03 déc. 199803 déc. 1998
    LAW 1001 LIMITED20 nov. 199820 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Peter David Smith en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 nov. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Nomination de Andrew John Moore en tant que secrétaire le 27 sept. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Matt Blake en tant que secrétaire le 27 sept. 2016

    1 pagesTM02

    État du capital au 28 sept. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 036710420004 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    21 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 036710420004

    1 pagesMR05

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2016

    État du capital au 06 janv. 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Rinku Patel en tant que directeur le 31 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Peter David Smith en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Adrian Colosso en tant que directeur le 31 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Rinku Patel en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    19 pagesAA

    Inscription de la charge 036710420004, créée le 29 avr. 2015

    39 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 036710420003 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2015

    État du capital au 29 janv. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Amanda Jane Emilia Massie en tant que secrétaire le 01 mai 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Matt Blake en tant que secrétaire le 01 mai 2014

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOORE, Andrew John
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secrétaire
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    215225290001
    PLUMMER, John
    Lamont Road
    SW10 OHL London
    8
    England
    England
    Administrateur
    Lamont Road
    SW10 OHL London
    8
    England
    England
    UkBritish147124850003
    BLAKE, Matt
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secrétaire
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    192427440001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secrétaire
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    188836160001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    PIGRAM, Ivor
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    British993440001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    AHEDO, Francisco Jose
    Paseo Poseidon No 12
    Madrid 28220
    FOREIGN Spain
    Administrateur
    Paseo Poseidon No 12
    Madrid 28220
    FOREIGN Spain
    SpainBritish125349900001
    BRAGOLI, Andrea
    57 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    Administrateur
    57 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    British55145700001
    COLES, Timothy Crispin Fitzgerald
    Forest Grange
    RH13 6HX Horsham
    Hurstwood House
    West Sussex
    Administrateur
    Forest Grange
    RH13 6HX Horsham
    Hurstwood House
    West Sussex
    EnglandBritish90464540003
    COLOSSO, Adrian
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Administrateur
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    EnglandBritish4555310002
    DAVIDOFF, Rony
    3 Hamelacha Street
    Tel Aviv
    67215
    Israel
    Administrateur
    3 Hamelacha Street
    Tel Aviv
    67215
    Israel
    Israeli52788780007
    ELIAS, Richard Joseph Raymond
    24 Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    Bevis Marks House
    United Kingdom
    Administrateur
    24 Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    Bevis Marks House
    United Kingdom
    EnglandBritish18192620002
    FARMER, Paul Robert
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    Administrateur
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    United KingdomBritish46071820001
    HOWDEN, David Philip
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish75271140001
    KAREV, Eyal
    Apartment 10a 112 West 72nd Street
    New York
    New York 10023
    Usa
    Administrateur
    Apartment 10a 112 West 72nd Street
    New York
    New York 10023
    Usa
    Israeli62908060001
    PATEL, Rinku
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Administrateur
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    EnglandBritish200346400001
    SMITH, Alan
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    Administrateur
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish62859550001
    SMITH, Peter David
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Administrateur
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United KingdomBritish201889340001
    WYLIE, Jacqueline
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Administrateur
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish106921840001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    06 juin 2016
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06249799
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2015
    Livré le 07 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All intellectual property, meaning any patent, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, etc. and the benefit of all applications and rights to use such assets of each chargor.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Senior Funding, Inc
    Transactions
    • 07 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 12 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 oct. 2013
    Livré le 04 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited (And Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 04 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 31 mai 2012
    Livré le 08 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 08 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 avr. 2010
    Livré le 14 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0