HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03671042 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 16 Eastcheap EC3M 1BD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2016 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2017 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2015 |
Quels sont les derniers d épôts pour HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter David Smith en tant que directeur le 30 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 nov. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Andrew John Moore en tant que secrétaire le 27 sept. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matt Blake en tant que secrétaire le 27 sept. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
État du capital au 28 sept. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 036710420004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2015 | 21 pages | AA | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 036710420004 | 1 pages | MR05 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Rinku Patel en tant que directeur le 31 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Peter David Smith en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Adrian Colosso en tant que directeur le 31 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Rinku Patel en tant qu'administrateur le 31 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2014 | 19 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 036710420004, créée le 29 avr. 2015 | 39 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 036710420003 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Jane Emilia Massie en tant que secrétaire le 01 mai 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Matt Blake en tant que secrétaire le 01 mai 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Andrew John | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | 215225290001 | |||||||
| PLUMMER, John | Administrateur | Lamont Road SW10 OHL London 8 England England | Uk | British | 147124850003 | |||||
| BLAKE, Matt | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | 192427440001 | |||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | 188836160001 | |||||||
| PALLOT, Hugh Glen | Secrétaire | 143 Gresham Road TW18 2AG Staines Middlesex | British | 14485660002 | ||||||
| PIGRAM, Ivor | Secrétaire | 93 Kingsfield Road Oxhey WD19 4TP Watford Hertfordshire | British | 993440001 | ||||||
| TJG SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 61729550001 | |||||||
| AHEDO, Francisco Jose | Administrateur | Paseo Poseidon No 12 Madrid 28220 FOREIGN Spain | Spain | British | 125349900001 | |||||
| BRAGOLI, Andrea | Administrateur | 57 Meadway Southgate N14 6NJ London | British | 55145700001 | ||||||
| COLES, Timothy Crispin Fitzgerald | Administrateur | Forest Grange RH13 6HX Horsham Hurstwood House West Sussex | England | British | 90464540003 | |||||
| COLOSSO, Adrian | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | England | British | 4555310002 | |||||
| DAVIDOFF, Rony | Administrateur | 3 Hamelacha Street Tel Aviv 67215 Israel | Israeli | 52788780007 | ||||||
| ELIAS, Richard Joseph Raymond | Administrateur | 24 Bevis Marks EC3A 7JB London Bevis Marks House United Kingdom | England | British | 18192620002 | |||||
| FARMER, Paul Robert | Administrateur | 10 Braintree Road CM8 2DD Witham Essex | United Kingdom | British | 46071820001 | |||||
| HOWDEN, David Philip | Administrateur | The Old Rectory Brill Road Ludgershall HP18 9PG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 75271140001 | |||||
| KAREV, Eyal | Administrateur | Apartment 10a 112 West 72nd Street New York New York 10023 Usa | Israeli | 62908060001 | ||||||
| PATEL, Rinku | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | England | British | 200346400001 | |||||
| SMITH, Alan | Administrateur | The Croft Green Lane Ardleigh CO7 7PB Colchester Essex | United Kingdom | British | 62859550001 | |||||
| SMITH, Peter David | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 | United Kingdom | British | 201889340001 | |||||
| WYLIE, Jacqueline | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 106921840001 | |||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Administrateur désigné | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008150001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howden Broking Group Limited | 06 juin 2016 | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 29 avr. 2015 Livré le 07 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All intellectual property, meaning any patent, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, etc. and the benefit of all applications and rights to use such assets of each chargor. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 oct. 2013 Livré le 04 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Group debenture | Créé le 31 mai 2012 Livré le 08 juin 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 avr. 2010 Livré le 14 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0