THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03671526 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?
Adresse du siège social | 88 Wood Street EC2V 7QF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 30 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2018 | 28 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2017 | 28 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2016 | 16 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2015 | 14 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2014 | 13 pages | 4.68 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal d'insolvabilité Court order insolvency:court order to replace | 5 pages | LIQ MISC OC | ||||||||||
Ordonnance du tribunal d'insolvabilité Court order insolvency:replacement of liquidator | 9 pages | LIQ MISC OC | ||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2013 | 13 pages | 4.68 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Grose en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Benjamin Toby Grose en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Démission d'un auditeur | 2 pages | AA03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Camomile Court 23 Camomile Street London EC3A 7LL* le 12 oct. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 03 oct. 2012
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Nomination de Stephen Paul Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2013 au 31 déc. 2012 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE, David Robert | Administrateur | Wood Street EC2V 7QF London 88 | England | British | Accountant | 76032910003 | ||||
ROWE, Reginald John Barnabas | Administrateur | Wood Street EC2V 7QF London 88 | England | British | Chartered Surveyor | 148690500001 | ||||
BRAINE, Anthony | Secrétaire | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
BARNES, Eric Malcolm | Administrateur | 148 Chapel Lane Ravenshead NG15 9DJ Nottingham Nottinghamshire | British | Company Director | 20256100002 | |||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Administrateur | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||
BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||
BOWDEN, Robert Edward | Administrateur | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||
BRAINE, Anthony | Administrateur | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||
CARTER, Simon Geoffrey | Administrateur | Camomile Street EC3A 7LL London 2nd Floor Camomile Court 23 | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Administrateur | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Administrateur | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||
GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | Camomile Street EC3A 7LL London 2nd Floor Camomile Court 23 | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||
GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||
GUNSTON, Michael Ian | Administrateur | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3079890002 | ||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Administrateur | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||
HINCHLEY, David | Administrateur | 20 Leconfield Garth Follifoot HG3 1NF Harrogate North Yorkshire | British | Managment Accountant | 21091680001 | |||||
JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||
METLISS, Cyril | Administrateur | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||
PELTZ, Daniel | Administrateur | 9 Cavendish Avenue St Johns Wood NW8 9JD London | United Kingdom | British | Director | 34366280004 | ||||
RITBLAT, John, Sir | Administrateur | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Administrateur | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||
ROBERTS, Graham Charles | Administrateur | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Administrateur | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||
SMITH, Stephen Paul | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||
SMITH, Stephen Paul | Administrateur | Camomile Street EC3A 7LL London 2nd Floor Camomile Court 23 | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||
WEBB, Nigel Mark | Administrateur | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 | ||||
WESTON SMITH, John Harry | Administrateur | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Third composite supplemental trust deed | Créé le 01 janv. 2007 Livré le 10 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All the principal of, and interest on all the debentures | |
Brèves mentions Land on the north west side of sleaford street, land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west of coldhams lane cambridge t/nos cb 162546, cb 107528 and cb 92528 together with all buildings and erections and fixtures and plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A composite supplemental trust deed | Créé le 29 août 2006 Acquis le 01 janv. 2007 Livré le 24 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Land on the north west side of sleaford street land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west side of coldhams lane cambridge (cambridge the beehive centre) t/nos CB162546 CB107528 CB92528. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A composite supplemental trust deed | Créé le 29 août 2006 Livré le 13 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Land on the north west side of sleaford street, land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west side of coldhams lane cambridge t/nos CB162546, CB107528 and CB92528. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 avr. 1999 Livré le 17 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0