THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED

THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03671526
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BLU (BC) LIMITED17 nov. 199817 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    30 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2018

    28 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2017

    28 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2016

    16 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2015

    14 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2014

    13 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:court order to replace
    5 pagesLIQ MISC OC

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    9 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2013

    13 pages4.68

    Cessation de la nomination de Stephen Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Benjamin Grose en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Benjamin Toby Grose en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Declaration of dividend 28/09/2012
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Démission d'un auditeur

    2 pagesAA03

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Camomile Court 23 Camomile Street London EC3A 7LL* le 12 oct. 2012

    2 pagesAD01

    État du capital après une attribution d'actions au 03 oct. 2012

    • Capital: GBP 88,884,750.76
    4 pagesSH01

    Nomination de Stephen Paul Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2013 au 31 déc. 2012

    3 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEE, David Robert
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Administrateur
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    EnglandBritishAccountant76032910003
    ROWE, Reginald John Barnabas
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Administrateur
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    EnglandBritishChartered Surveyor148690500001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BARNES, Eric Malcolm
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director20256100002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    Administrateur
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    Administrateur
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HINCHLEY, David
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishManagment Accountant21091680001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    Administrateur
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    United KingdomBritishDirector34366280004
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    SMITH, Stephen Paul
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    Administrateur
    Camomile Street
    EC3A 7LL London
    2nd Floor Camomile Court 23
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third composite supplemental trust deed
    Créé le 01 janv. 2007
    Livré le 10 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the principal of, and interest on all the debentures
    Brèves mentions
    Land on the north west side of sleaford street, land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west of coldhams lane cambridge t/nos cb 162546, cb 107528 and cb 92528 together with all buildings and erections and fixtures and plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A composite supplemental trust deed
    Créé le 29 août 2006
    Acquis le 01 janv. 2007
    Livré le 24 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north west side of sleaford street land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west side of coldhams lane cambridge (cambridge the beehive centre) t/nos CB162546 CB107528 CB92528.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 24 janv. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A composite supplemental trust deed
    Créé le 29 août 2006
    Livré le 13 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north west side of sleaford street, land and buildings lying to the north east of sleaford street and land on the south west side of coldhams lane cambridge t/nos CB162546, CB107528 and CB92528. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 13 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 1999
    Livré le 17 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transactions
    • 17 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE BEEHIVE CENTRE CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 oct. 2012Commencement of winding up
    28 nov. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0