OPAL WAREHOUSE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPAL WAREHOUSE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03673654
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARRINGTON IMPORT/EXPORT LIMITED25 nov. 199825 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    47 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    47 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    45 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    44 pagesWU07

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY à 2 st Peters Square Manchester M2 3EY le 10 août 2017

    2 pagesAD01

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:annual progress report for period up to 24/02/2016
    41 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    49 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 31 janv. 2014

    46 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 sept. 2013

    62 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    117 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* le 18 mars 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 déc. 2012

    État du capital au 11 déc. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OPAL WAREHOUSE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL WAREHOUSE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 mai 2005
    Livré le 28 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Great newton hall lower gill street liverpool t/nos ms 308271 & MS367150, fiveways hall stafford street wolverhampton t/nos WM736606, WM736813 and sf 48941 and grosvenor house newarke street leicester t/nos LT346790, lt 303899, lt 346789, lt 38542 and lt 133210. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Second supplemental debenture
    Créé le 17 oct. 2003
    Livré le 31 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 21,23,25 and 25A the magazine public house 27,29,31,31A newarke street leicester LE1 5SP together with 13 marble street leicester LT3467990, LT346789, LT303899, LT38542 and LT133210. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 31 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 18 mars 2003
    Livré le 29 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a barley mow inn lower stafford street wolverhampton west midlands t/n SF48941, f/h property k/a five ways garage stafford street wolverhampton west midlands t/n WM736606 and the l/h land k/a five ways garage stafford street wolverhampton west midlands t/n WM736813 (the additional properties) the assets and rights all rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 29 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture creating fixed and floating charges
    Créé le 07 nov. 2002
    Livré le 20 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over deposit account
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter issued by the chargee on 11 decemeber 2001 (as amended by a supplemental facility letter dated 19 december 2001)
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all monies standing to the credit of the sterling account maintained by the company with the lender and numbered 01590359.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all that f/h property situate at and k/a 4-14 (even) great newton street and 7-15 (odd) gill street liverpool t/n MS308271 and all that f/h property being land on the east side of gill street liverpool t/n MS367150, together with all rights powers easements and liberties... See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2001
    Livré le 23 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 23 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 2001
    Livré le 17 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the east side of gill street liverpool and 4-14 (even) great newton street and 7-15 (odd) gill street liverpool t/no's;- MS367150 and MS308271.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 oct. 2000
    Livré le 10 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OPAL WAREHOUSE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 mars 2013Administration started
    25 févr. 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DateType
    13 sept. 2019Conclusion of winding up
    10 févr. 2014Petition date
    25 févr. 2014Commencement of winding up
    20 févr. 2020Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    practitioner
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0