NIKE MERCURIAL LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNIKE MERCURIAL LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03674789
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NIKE MERCURIAL LTD. ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Adresse du siège social
    c/o DUFF & PHELPS LTD.
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UMBRO HOLDINGS LIMITED27 avr. 199927 avr. 1999
    ALTERAMBER LIMITED26 nov. 199826 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    22 pages4.71

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    5 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 avr. 2015

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Nike Camberwell Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XN à C/O Duff & Phelps Ltd. the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 20 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 6

    5 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2014

    État du capital au 23 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,467,409.83
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 déc. 2013

    État du capital au 24 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,467,409.83
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2013

    8 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed umbro LTD.\certificate issued on 18/06/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name18 juin 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name18 juin 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Nomination de Mr Evan Scott Reynolds en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Hare en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Umbro House Lakeside Cheadle Cheshire SK8 3GQ United Kingdom* le 29 mai 2013

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    14 pagesAA

    Nomination de Evan Scott Reynolds en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gary Brown en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    État du capital après une attribution d'actions au 28 mai 2012

    • Capital: GBP 1,467,409.83
    4 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de NIKE MERCURIAL LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REYNOLDS, Evan Scott
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Secrétaire
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    178625560001
    HANSON, Grant Winston
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Administrateur
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    United StatesAmericanBusiness Executive128634930001
    REYNOLDS, Evan Scott
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Administrateur
    c/o Duff & Phelps Ltd.
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    United StatesAmericanLegal Counsel174461900001
    HARE, David Andrew
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Secrétaire
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    British94574310001
    MONAGHAN, Mark
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    Secrétaire
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    British48690170001
    RONNIE, Christopher
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director79360390001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLAKER, James
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector116430430001
    BARFIELD, Richard Arthur
    South Persie
    Bridge Of Cally
    PH10 7LQ Blairgowrie
    Perthshire
    Administrateur
    South Persie
    Bridge Of Cally
    PH10 7LQ Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishCompany Director53292090001
    BIRD III, Lewis Leo
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    Administrateur
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    United StatesBusiness Executive125383590001
    BROWN, Gary James
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCfo125196870001
    COOK, Matthew Adrian
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    Administrateur
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    BritishBusiness Executive128768440001
    CORBIDGE, Mark Andrew
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    Administrateur
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    EnglandBritishCompany Director55506050001
    DINGES, Gregory Clark
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    Administrateur
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    AmericanBusiness Executive128857410001
    DOUGHTY, Nigel Edward
    14 Park Village East
    NW1 7PX London
    Administrateur
    14 Park Village East
    NW1 7PX London
    EnglandBritishManager51589780004
    HASLEHURST, Geoffrey Peter
    Rivermead
    Avenue Road
    SL6 1UG Maidenhead
    Berks
    Administrateur
    Rivermead
    Avenue Road
    SL6 1UG Maidenhead
    Berks
    United KingdomBritishDirector1103560002
    HENRY, Colin
    10 Devonshire Place
    W1G 6HS London
    Administrateur
    10 Devonshire Place
    W1G 6HS London
    BritishProduct Director91662260001
    MAKIN, Steve Richard
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCfo133477340001
    MCCAFFERTY, Mark
    39 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Administrateur
    39 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector61788610002
    MCGUIGAN, Peter
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector136211350001
    MCLAUGHLIN, Eunan Patrick
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside
    SK8 3GQ Cheadle
    Umbro House
    Cheshire
    United Kingdom
    NetherlandsIrishDirector146619970001
    MONAGHAN, Mark
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    Administrateur
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    BritishBusiness Administrator48690170001
    PROTHERO, Martin
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    Administrateur
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    BritishBusiness Admnistrator106133480001
    ROE, Bruce Patrick
    6 Clifton Court Cherrywood Drive
    Putney
    SW15 6DS London
    Administrateur
    6 Clifton Court Cherrywood Drive
    Putney
    SW15 6DS London
    BritishFund Manager51826160001
    RONNIE, Christopher
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director79360390001
    SMULDERS, Patrick
    98 Oxford Gardens
    W10 6NG London
    Administrateur
    98 Oxford Gardens
    W10 6NG London
    DutchDirector76231010002
    STROBEL, Marc
    Moerikestrasse 16
    Frankfurt Am Main 60320
    FOREIGN Germany
    Administrateur
    Moerikestrasse 16
    Frankfurt Am Main 60320
    FOREIGN Germany
    GermanDirector64016490001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    NIKE MERCURIAL LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of shares
    Créé le 28 avr. 2004
    Livré le 06 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and its subsidiaries, each borrower and its respective subsidiaries to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares and all allotments, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 06 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 août 2003
    Livré le 11 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from umbro international limited to the trustee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property at lakeside 5400, cheadle royal business park, wilmslow road, cheadle, cheshire t/n GM839134.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 11 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    An assignment by way of security
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 06 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The "shareholders undertaking" (including but not limited to it's right to require subscription for additional securities). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limitedas Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 13 juil. 2001
    Livré le 01 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the investors obligations and liabilities to the company under the shareholders undertaking being notwithstanding any insolvency any other deterioration in the financial situation of the company or any other event or circumstance each investors subscription by the relevant date specified in the shareholders undertaking for its proportion of securities in accordance with the shareholders undertaking provided that the total amount subscribed thereunder shall not exceed £15,800,000
    Brèves mentions
    All right title and interest under and to the shareholders undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited as Trustee for the Beneficiaries Which Expression Shall Includeany Person for the Time Being Appointed as Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of and in Accordance with the Intercreditor Agreement (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of rental deposit
    Créé le 05 mai 1999
    Livré le 20 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Rent service charges insurance premiums or other contribution to the cost of insurance and other payments payable to the chargee by the company under the lease dated 5 may 1999 whether or not reserved by way of rent and whether or not formally demanded and all costs and expenses arising out of breach by the company of the covenants and conditions in the lease or of obligations in the rent deposit deed
    Brèves mentions
    The company's interest in an interest bearing account maintained at a bank (namely the sumitomo bank limited) by the chargee in which to hold the sum which the company has provided to the chargee to meet liabilities which is for the time being unexpended and which at the date of the rent deposit deed is a total sum (including vat) of £61,922.50.
    Personnes ayant droit
    • Mid U.K.Limited
    Transactions
    • 20 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental deposit
    Créé le 05 mai 1999
    Livré le 20 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Rent service charges insurance premiums or other contribution to the cost of insurance and other payments payable to the chargee by the company under the lease dated 5 may 1999 whether or not reserved by way of rent and whether or not formally demanded and all costs and expenses arising out of breach by the company of the covenants and conditions in the lease or of obligations in the rent deposit deed
    Brèves mentions
    The company's interest in an interest bearing account maintained at a bank (namely the sumitomo bank limited) by the chargee in which to hold the sum which the company has provided to the chargee to meet liabilities which is for the time being unexpended and which at the date of the rent deposit deed is a total sum (including vat) of £77,852.56.
    Personnes ayant droit
    • Mid U.K.Limited
    Transactions
    • 20 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 05 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company,formerly known as alteramber limited,to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bny International Limited,as "Trustee" (As Defined)
    Transactions
    • 05 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    NIKE MERCURIAL LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 avr. 2015Commencement of winding up
    26 août 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Phillip Francis Duffy
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Keith Allan Marshall
    Duff & Phelps Ltd 1 City Square
    LS1 2ES Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd 1 City Square
    LS1 2ES Leeds
    West Yorkshire
    Benjamin John Wiles
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0