AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED

AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03675469
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLADEDALE (EAST MIDLANDS) LIMITED29 janv. 200729 janv. 2007
    CLARKE HOMES LIMITED12 janv. 199912 janv. 1999
    BROOMCO (1732) LIMITED27 nov. 199827 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP United Kingdom à 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH le 22 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 janv. 2017

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Aileen Payne en tant que directeur le 14 déc. 2016

    1 pagesTM01

    État du capital au 28 avr. 2016

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2016

    État du capital au 15 avr. 2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Nomination de Mrs Aileen Payne en tant qu'administrateur le 30 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed gladedale (east midlands) LIMITED\certificate issued on 26/10/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name26 oct. 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de 30 High Street Westerham England and Wales TN16 1RG à Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP le 23 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mars 2015

    État du capital au 06 mars 2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Secrétaire
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    147808200001
    LEWIS, Colin Edward
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Administrateur
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Administrateur
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    AYTON, Brian Robert
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector34063800002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    HIRST, Stephen Jeremy
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    Secrétaire
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    BritishCompany Director95787000001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    9 Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    9 Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector75879360004
    AYTON, Brian Robert
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector34063800002
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    GREGORY, Michael George
    62 Gillway Lane
    B79 8PL Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    62 Gillway Lane
    B79 8PL Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Director59709440001
    GRIFFITHS, Martin Paul
    10 Farrier Close
    ST15 8XP Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    10 Farrier Close
    ST15 8XP Stone
    Staffordshire
    BritishDirector92415430001
    HARRISON, Jolyon Leonard
    Woodbine Cottage Wigginton Road
    YO32 2RJ York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Woodbine Cottage Wigginton Road
    YO32 2RJ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector58843110002
    HIRST, Stephen Jeremy
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    Administrateur
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    United KingdomBritishGroup Finance Director95787000001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director148459300001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo207729000002
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director90170480001
    PAYNE, Aileen
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Administrateur
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director200102790001
    RILEY, Peter Allan
    Middleheath Lodge
    Sheriffhales
    TF11 8RW Shropshire
    Administrateur
    Middleheath Lodge
    Sheriffhales
    TF11 8RW Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director111482770001
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director42298130002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond and floating charge
    Créé le 28 juin 2012
    Livré le 09 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each residential obligor to any residential secured party and any bacs creditor on any account whatsoever and all monies due or to become due from each commercial obligor to any commercial secured party and any bacs creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over the whole of the charged assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 09 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    English security agreement
    Créé le 28 juin 2012
    Livré le 04 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any residential secured party and all monies due or to become due from any obligor to any bacs creditor and all monies due or to become due from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all assets including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 09 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 2005
    Livré le 01 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the west side of park lane, basford, nottingham t/no NT303609 and NT309448. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 juin 2005
    Livré le 29 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a land at park lane pinxton t/n DY370015 the property k/a christ church old national school madison street tunstall t/n SF42405 the property k/a land at the north end of ashwood avenue kirkby in ashfield t/n NT405035. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2005
    Livré le 29 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land at park lane pinxton t/no DY370015, the property k/a christ church old national school madison street tunstall t/no SF42405 and the property k/a land at the north end of ashwood, avenue kirkby in ashfield t/no NT405035. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 janv. 2005
    Livré le 14 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at ashwood avenue kirkby in ashfield nottinhamshire,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 28 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at park lane pinxton derbyshire t/no DY356888 (part). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 avr. 2003
    Livré le 03 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land fronting high street parsonage street and bank street stoke on trent staffordshire t/nos: SF115326 and part SF351115. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 avr. 2003
    Livré le 03 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £382,500 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property at high street stoke on trent staffordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wainvale Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at codnor park ironville derbyshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 janv. 2000
    Livré le 21 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AVANT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 déc. 2017Dissolved on
    05 janv. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Paul Andrew Flint
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0