PHAETON RESEARCH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHAETON RESEARCH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03676782
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    • Recherche-développement en biotechnologie (72110) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Trent House Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENTERION LIMITED13 avr. 200413 avr. 2004
    PHAETON RESEARCH LIMITED20 avr. 199920 avr. 1999
    NOTTCOR 84 LIMITED01 déc. 199801 déc. 1998

    Quels sont les derniers comptes de PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 036767820008 en totalité

    4 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 036767820006 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 036767820007 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2015

    État du capital au 03 déc. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gordon Biggart Cameron le 03 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Inscription de la charge 036767820008, créée le 01 déc. 2015

    15 pagesMR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 déc. 2014

    État du capital au 05 déc. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Inscription de la charge 036767820007, créée le 30 oct. 2014

    60 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    9 pagesAA

    Nomination de Dr Mark Egerton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 janv. 2014

    État du capital au 20 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Roger Burdett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 036767820006

    17 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Newmarket Road Fordham Cambridgeshire CB7 5WW* le 28 août 2013

    1 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    8 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PHAETON RESEARCH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMERON, Gordon Biggart
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    England
    Secrétaire
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    England
    157497500001
    CAMERON, Gordon Biggart
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    Administrateur
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    United KingdomBritishCfo126030290002
    EGERTON, Mark, Dr.
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    Administrateur
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    EnglandBritishCeo183691090001
    CAMERON, Gordon Biggart
    Newmarket Road
    CB7 5WW Fordham
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Newmarket Road
    CB7 5WW Fordham
    Cambridgeshire
    United KingdomCfo126030290001
    DOWNING, Ian
    28 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Coventry
    Secrétaire
    28 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Coventry
    BritishDirector110684080001
    GATFORD, Kerry Louise
    19 Station Street
    LE11 5ED Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire désigné
    19 Station Street
    LE11 5ED Loughborough
    Leicestershire
    British900016290001
    KENNEDY, Michelle
    Newmarket Road
    CB7 5WW Fordham
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Newmarket Road
    CB7 5WW Fordham
    Cambridgeshire
    149464270001
    SOUSTER, Nigel Graham
    12 Rowley Close
    B79 9LN Edingale
    Staffordshire
    Secrétaire
    12 Rowley Close
    B79 9LN Edingale
    Staffordshire
    British45986480002
    BROWN, Julia Diane
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    Administrateur
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    BritishSolicitor62842870002
    BURDETT, Roger Leonard
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    England
    Administrateur
    Mere Way
    Ruddington
    NG11 6JS Nottingham
    Trent House
    England
    United KingdomBritishCeo163337290001
    COWAN, Desmond Joseph Paul Edward
    Newmarket Road
    CB7 5AW Fordham
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Newmarket Road
    CB7 5AW Fordham
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director135633580001
    DAVIS, Stanley Stewart, Professor
    19 Cavendish Crescent North
    The Park
    NG7 1BA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    19 Cavendish Crescent North
    The Park
    NG7 1BA Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishProfessor Of Pharmacy2320180001
    DOWNING, Ian
    28 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Coventry
    Administrateur
    28 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Coventry
    BritishDirector110684080001
    GATFORD, Kerry Louise
    19 Station Street
    LE11 5ED Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur désigné
    19 Station Street
    LE11 5ED Loughborough
    Leicestershire
    British900016290001
    LEE, Simon Anthony
    59 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    59 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector84325750001
    NEWMAN, Stephen Peter, Dr
    24 Dale Lane
    Chilwell
    NG9 4EA Nottingham
    Administrateur
    24 Dale Lane
    Chilwell
    NG9 4EA Nottingham
    BritishMedical Physicist13896670001
    SOUSTER, Nigel Graham
    12 Rowley Close
    B79 9LN Edingale
    Staffordshire
    Administrateur
    12 Rowley Close
    B79 9LN Edingale
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector45986480002
    WILDING, Ian, Dr
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishPharmacist111933510001

    PHAETON RESEARCH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 02 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 05 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 05 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 déc. 2013
    Livré le 12 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 janv. 2005
    Livré le 21 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each of the security trustee and the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Investments PLC Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Security Beneficiaries(The Security Trustee)
    Transactions
    • 21 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mars 2004
    Livré le 03 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 juin 2000
    Livré le 05 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0