TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED

TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03680937
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAW 1031 PLC03 déc. 199803 déc. 1998

    Quels sont les derniers comptes de TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2024

    8 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2023

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    État du capital après une attribution d'actions au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 45,050,000
    3 pagesSH01

    État du capital au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amount arising from reduction credited to profit and loss account 09/03/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of directors/ change of registered address 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    8 pagesMA

    Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 15 août 2021

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 16 août 2020

    19 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 18 août 2019

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritish299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629410001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    DEEGAN, Jayne
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    Secrétaire
    5 Hardstruggle Row
    Eskdaleside
    YO22 5ET Sleights
    North Yorkshire
    British94870790001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175489640001
    MILLER, Nicola Jane
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    Secrétaire
    27 Hillston Close
    TS26 0PE Hartlepool
    British95390370001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161615930001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BRAMALL, Colin Stephen
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Well House 131a High Street
    Riseley
    MK44 1DJ Bedford
    Bedfordshire
    British62475470002
    BUTTERWORTH, John William Blackstock, Hon
    5a Montpelier Grove
    NW5 2XD London
    Administrateur
    5a Montpelier Grove
    NW5 2XD London
    United KingdomBritish37919580001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish1812400001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    DUNSTAN, Jennifer Anne
    24 Anhalt Road
    SW11 4NX London
    Administrateur
    24 Anhalt Road
    SW11 4NX London
    EnglandBritish61818060002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRANT, Martin James
    Oak House
    Waverley Edge
    CV8 3LW Bubbenhall
    Warwickshire
    Administrateur
    Oak House
    Waverley Edge
    CV8 3LW Bubbenhall
    Warwickshire
    UkBritish82731440001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    HANDS, Guy
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    British2519120002
    HOWES, Lewis
    3 Webster Close
    GU22 0LR Woking
    Surrey
    Administrateur
    3 Webster Close
    GU22 0LR Woking
    Surrey
    American-Uk62776210002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Administrateur
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Administrateur
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Administrateur
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    PUNJA, Riaz
    Flat 34
    Collingwood House 8 Clipstone Street
    W1 London
    Administrateur
    Flat 34
    Collingwood House 8 Clipstone Street
    W1 London
    British58870910001
    SAMMONS, Nigel Anthony
    Hutton Lodge
    Hutton Magna
    DL11 7HQ Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hutton Lodge
    Hutton Magna
    DL11 7HQ Richmond
    North Yorkshire
    British59809250002
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Administrateur
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritish141561650001
    SIMPSON, Mark
    Library Farm Oxford Road
    Garsington
    OX44 9DA Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Library Farm Oxford Road
    Garsington
    OX44 9DA Oxford
    Oxfordshire
    British125353550001
    SMELT, Richard John
    Orchard House 100 High Street
    Wargrave
    RG10 8DE Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Orchard House 100 High Street
    Wargrave
    RG10 8DE Reading
    Berkshire
    British59819540003
    TURNBULL, Ronald
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Administrateur
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British63331360001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3680951
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TUDOR STREET ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 sept. 2025Due to be dissolved on
    27 mars 2023Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0