BAGLAN GENERATING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAGLAN GENERATING LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03689741
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRUSHELFCO (NO.2487) LIMITED29 déc. 199829 déc. 1998

    Quels sont les derniers comptes de BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2020
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 déc. 2021
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 janv. 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 déc. 2020
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    legacy

    pagesANNOTATION

    legacy

    pagesANNOTATION

    legacy

    pagesANNOTATION

    Cessation de la nomination de Michael David Higginbotham en tant que directeur le 06 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    6 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Qui sont les dirigeants de BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLDER, Jeffrey James
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    United Kingdom
    Administrateur
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    United Kingdom
    EnglandBritish231110670001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ALTER DOMUS (UK) LIMITED
    St. Swithin's Lane
    EC4N 8AD London
    18
    England
    Secrétaire
    St. Swithin's Lane
    EC4N 8AD London
    18
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement7562881
    168128980002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    26-28 Market Street
    WA14 1PF Altrincham
    Webber House
    Cheshire
    Secrétaire
    26-28 Market Street
    WA14 1PF Altrincham
    Webber House
    Cheshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish56868460002
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Administrateur
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    DANIELL, Paul Nigel
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    British62463920001
    DIGBY, Mark Damien
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Administrateur
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Irish103125610001
    DYCKHOFF, James Christopher
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish203266490001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish127244240001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HEPPENSTALL, Bruce Michael Amos
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    WalesBritish154931100001
    HIGGINBOTHAM, Michael David
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    Wales
    Administrateur
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    Wales
    EnglandBritish195480240001
    HUBERT, Glenn Joseph
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    CanadaCanadian172978940001
    LOWE, James Alfred
    Red Lodge, Bishops Heath
    Bishopsgate Road, Englefield Green
    TW20 0YJ Egham
    Surrey
    Administrateur
    Red Lodge, Bishops Heath
    Bishopsgate Road, Englefield Green
    TW20 0YJ Egham
    Surrey
    British And Usa66020990001
    MCCULLOUGH, Kevin
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    Wales
    Administrateur
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    Wales
    United KingdomBritish193351870001
    MCLEISH, Douglas Stuart
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    EnglandBritish174474590001
    METCALFE, Edward
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    United KingdomBritish124389930003
    MULHOLLAND, Diarmaid Patrick
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    ItalyIrish116288460001
    OTERO-NOVAS MIRANDA, Irene
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    United Kingdom
    Administrateur
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Gwent
    United Kingdom
    United KingdomSpanish241974140002
    PARSONS, Gordon Ian Winston
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish183966450004
    PATERSON, Robert Murray
    Centenary Way
    Sutton Bridge
    PE12 9TF Spalding
    Sutton Bridge Power Station
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centenary Way
    Sutton Bridge
    PE12 9TF Spalding
    Sutton Bridge Power Station
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish177424320001
    PHILP, Harry
    11 Westmoreland Place
    Mount Avenue Ealing
    W5 1QE London
    Administrateur
    11 Westmoreland Place
    Mount Avenue Ealing
    W5 1QE London
    EnglandBritish74885510001
    PROBERT, Stephen William
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    British74884840003
    RISINGER, Marlin
    14 Argyll Road
    W8 7BG London
    Administrateur
    14 Argyll Road
    W8 7BG London
    United States101299660001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Administrateur
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British77049790002
    SAUL, Christopher Francis Irving
    11 Chepstow Villas
    W11 3EE London
    Administrateur
    11 Chepstow Villas
    W11 3EE London
    United KingdomBritish106157160001
    TROY, Teresa
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    CanadaCanadian172980410001
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish96648390001
    WALBRIDGE, Jonathan Paul
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Administrateur
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish139791650050

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BAGLAN GENERATING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Wales
    06 avr. 2016
    West Nash Road
    Nash
    NP18 2BZ Newport
    Severn Power Station
    Wales
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement08249830
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BAGLAN GENERATING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 mars 2019
    Livré le 29 mars 2019
    En cours
    Brève description
    Baglan power station, baglan, port talbot (title number CYM575178), among others. For more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 déc. 2017
    Livré le 19 déc. 2017
    En cours
    Brève description
    First fixed charge over accounts and first legal mortgage with respect to investments (as defined in the instrument). For more details please refer to the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2015
    Livré le 02 mai 2015
    En cours
    Brève description
    (1) freehold at baglan power station, baglan, port talbot, SA12 7GE registered at the land registry with title number CYM575178, (2) leasehold at tennant canal pumphouse, baglan bay, neath registered at the land registry with title number CYM371286 and CYM377544, (3) deed of grant relating to electricity assets dated 21 july 2006, (4) deed of easement of land dated 20 july 2007, (5) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 21 july 2006, (6) deed of grant relating to the neath canal pipeline dated 21 july 2006, (7) deed of covenant regarding various property obligations dated 18 october 2012, (8) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 3 july 2002, (9) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 8 march 2004, (10) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 3 july 2002, (11) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 21 july 2006, (12) deed of grant relating to the tennant canal pipeline dated 21 july 2006, (13) deed of easement relating to the tennant canal pipeline dated 12 february 2007, (14) deed of grant of electricity cable easement dated 30 march 2007 and (15) lease of easement relating to the tennant canal pipeline dated 15 october 2001. for more details of land or intellectual property charged please refer to the instrument.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 02 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2014
    Livré le 10 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H title absolute in baglan power station baglan port talbot t/no CYM575178, l/h title absolute in tennant canal pumphouse baglan bay neath t/no CYM371286 and good l/h title in land adjoining the tennant canal pumphouse baglan bay neath t/no CYM377544.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 10 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 24 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2014
    Livré le 10 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 10 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 24 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2014
    Livré le 10 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 10 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 24 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 oct. 2013
    Livré le 18 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H land t/no CYM575178 (land at baglan power station, baglan, port talbot). Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 18 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 02 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 02 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 02 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H interest in land with title number:WA699 (land at baglan bay lying between the river neath and western avenue). Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 02 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 oct. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 18 oct. 2012
    Livré le 22 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor, the company and si power holdings limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares being 150,000,003 ordinary shares of £1 and all other shares owned by the chargor and related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited
    Transactions
    • 22 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 04 août 2000
    Livré le 05 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee granted by way of security for the performance of the obligationsof ige to perform an undertaking granted by ige to the mortgagee pursuant to schedule 10 to the sell-down agreement (as defined) that ige will procure that the bpl shares (as defined) are sold and transferred to the mortgage on the transfer date (as defined)
    Brèves mentions
    All shares in issue in the capital of baglan pipeline limited ("bpl") at the date of the legal mortgage and any other shares in the capital of bpl at any time and from time to time held by the mortgagor (all of such shares being the "bpl shares"). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bp Chemicals Limited
    Transactions
    • 05 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BAGLAN GENERATING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mars 2021Petition date
    24 mars 2021Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    16th Floor 1 Westfield Avenue
    Stratford
    E20 1HZ London
    practitioner
    16th Floor 1 Westfield Avenue
    Stratford
    E20 1HZ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0